Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 24 tarjetas
03/04/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-149463

Nombramientos — 03/04/2019

Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 33153 , F 120, S 8, H M 44861, I/A 230 (27.03.19).

10/01/2019 Sec. I Situación concursal Madrid
Madrid-8219

Situación concursal — 10/01/2019

Situación concursal. Procedimiento concursal 1391/2018. FIRME: Si, Fecha de resolución 31/10/2018. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 MERCANTIL DE MADRID. Juez: JUEZ: MOISES GUILLAMON RUIZ. Res...

08/03/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-110233

Revocaciones — 08/03/2018

Revocaciones. Apoderado: MARIN RUIZ JOSE-CARLOS;MARIN RUIZ CARLOS;MARIN RUIZ JOSE-CARLOS;MARIN RUIZ JOSE- CARLOS;MARIN RUIZ JOSE-CARLOS. Datos registrales. T 33153 , F 115, S 8, H M 44861, I/A 227 (27.02.18).

19/02/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-80267

Nombramientos — 19/02/2018

Nombramientos. Apoderado: BOUNATIAN BENATOV VEGA LIV INGEBJORG LEONARDA. Datos registrales. T 33153 , F 114, S 8, H M 44861, I/A 226 (12.02.18).

30/05/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-224608

Revocaciones — 30/05/2017

Revocaciones. Apoderado: ALEGRET TERRES XAVIER;ALEGRET TERRES XAVIER. Datos registrales. T 33153 , F 108, S 8, H M 44861, I/A 219 (22.05.17).

30/05/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-224609

Nombramientos — 30/05/2017

Nombramientos. Apoderado: PAWEL KUZIEMSKI KRZYSZTOF;MARTIN GOSALVEZ RICARDO;DEL POZO VINDEL LUIS MARIA;APARICI MARTIN FELIX. Datos registrales. T 33153 , F 108, S 8, H M 44861, I/A 220 (22.05.17).

12/01/2017 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-14742

Ampliación de capital — 12/01/2017

Ampliación de capital. Suscrito: 3.244.920,00 Euros. Desembolsado: 3.244.920,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.244.920,00 Euros. Resultante Desembolsado: 9.244.920,00 Euros. Datos registrales. T 33153 , F 107, S 8, H M 4...

17/11/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-465261

Nombramientos — 17/11/2016

Nombramientos. Apoderado: CALDERON DELGADO FRANCISCO. Datos registrales. T 33153 , F 106, S 8, H M 44861, I/A 216 (10.11.16).

14/06/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-250812

Nombramientos — 14/06/2016

Nombramientos. Apoderado: ALEGRET TERRES XAVIER. Datos registrales. T 33153 , F 103, S 8, H M 44861, I/A 208 ( 6.06.16).

25/08/2015 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-350821

Reelecciones — 25/08/2015

Reelecciones. Consejero: DE LA REINA MONTERO ANTONIO JUAN;VEGA CALLEJA JOSEFINA. Secretario: DE LA REINA MONTERO ANTONIO JUAN. Consejero: ALFONSO SANCHEZ ANTONIO. Cons.Del.Sol: VEGA CALLEJA JOSEFINA. Datos registrales....

31/03/2015 Sec. I Fusión por unión Madrid
Madrid-137488

Fusión por unión — 31/03/2015

Fusión por unión. Sociedades que se fusiónan: EUROCONSULT ANDALUCIA SA. EUROCONSULT CASTILLA LA MANCHA SA. EUROCONSULT CASTILLA Y LEON SA. EUROCONSULT GALICIA SA. EUROCONSULT OCT SA. ANALISI I CONTROL DE PROJECTES CATAL...

29/08/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-349743

Nombramientos — 29/08/2014

Nombramientos. Apoderado: ANDRES ALVAREZ INDALECIO. Datos registrales. T 29399 , F 177, S 8, H M 44861, I/A 201 (20.08.14).

03/04/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-149249

Nombramientos — 03/04/2014

Nombramientos. Apoderado: MARTIN GOSALVEZ RICARDO. Datos registrales. T 29399 , F 175, S 8, H M 44861, I/A 197 (26.03.14).

03/04/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-149250

Nombramientos — 03/04/2014

Nombramientos. Apoderado: LUQUI VALLES SERGIO. Datos registrales. T 29399 , F 175, S 8, H M 44861, I/A 198 (26.03.14).

03/04/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-149251

Nombramientos — 03/04/2014

Nombramientos. Apoderado: APARICI MARTIN FELIX. Datos registrales. T 29399 , F 176, S 8, H M 44861, I/A 199 (27.03.14).

24/02/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-84917

Nombramientos — 24/02/2014

Nombramientos. Apoderado: MARTIN GOZALVEZ RICARDO. Datos registrales. T 29399 , F 173, S 8, H M 44861, I/A 194 (13.02.14).

04/06/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-256043

Nombramientos — 04/06/2013

Nombramientos. Apoderado: VADILLO MARTIN JUAN CARLOS. Datos registrales. T 29399 , F 166, S 8, H M 44861, I/A 181 (27.05.13).

04/06/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-256044

Nombramientos — 04/06/2013

Nombramientos. Apoderado: LUIS CASIS MANUEL. Datos registrales. T 29399 , F 166, S 8, H M 44861, I/A 182 (27.05.13).

09/05/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-214632

Nombramientos — 09/05/2013

Nombramientos. Apoderado: BOUZA RODRIGUEZ MARIA GENARA. Datos registrales. T 29399 , F 164, S 8, H M 44861, I/A 179 (29.04.13).

09/05/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-214633

Nombramientos — 09/05/2013

Nombramientos. Apoderado: DIEZ PASCUA BEATRIZ. Datos registrales. T 29399 , F 165, S 8, H M 44861, I/A 180 (29.04.13).

14/03/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-125856

Nombramientos — 14/03/2013

Nombramientos. Apoderado: MARIN RUIZ JOSE CARLOS;FERRERAS SANCHEZ MANUEL ROBERTO. Datos registrales. T 29399 , F 164, S 8, H M 44861, I/A 178 ( 6.03.13).

06/03/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-111842

Nombramientos — 06/03/2013

Nombramientos. Apoderado: LUQUI VALLES SERGIO. Datos registrales. T 29399 , F 163, S 8, H M 44861, I/A 176 (25.02.13).

11/12/2012 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-512155

Modificaciones estatutarias — 11/12/2012

Modificaciones estatutarias. 20. Funcionamiento Junta Gral.-. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.euroconsult.es. Datos registrales. T 29399 , F 161, S 8, H M 44861, I/A 173 (30.11.12).

11/12/2012 Sec. I Otros conceptos: APROBACION DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Madrid
Madrid-512156

Otros conceptos: aprobacion de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales — 11/12/2012

Otros conceptos: APROBACION DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 29399 , F 161, S 8, H M 44861, I/A 174 (30.11.12).