Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 6 tarjetas
25/05/2018 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-222078

Disolución — 25/05/2018

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 33754 , F 223, S 8, H M 607512, I/A 9 (18.05.18).

10/11/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-441418

Nombramientos — 10/11/2017

Nombramientos. Apoderado: AEDAS HOMES SA. Datos registrales. T 33754 , F 221, S 8, H M 607512, I/A 8 (31.10.17).

04/08/2017 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-322161

Sociedad unipersonal — 04/08/2017

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: HIPOTECA 43 LUX SARL. Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: AEDAS HOMES SL. Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SPV...

28/07/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-311887

Nombramientos — 28/07/2017

Nombramientos. Apoderado: OÑATE RINO MIGUEL;MARTINEZ MONTERO DAVID;DELGADO MONTERO ALBERTO;GRACIA COLLDEFORNS ENRIQUE;MORALES ASUA CORO;SOTO MONTENEGRO MERCEDES;OLLERO BARRERA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 33754...

28/07/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-311888

Nombramientos — 28/07/2017

Nombramientos. Apoderado: OÑATE RINO MIGUEL;MARTINEZ MONTERO DAVID;DELGADO MONTERO ALBERTO;GRACIA COLLDEFORNS ENRIQUE;GALVEZ CAPO SERGIO;DUARTE MACARRO ESTHER;GARCIA HORCAJADA MARIA JOSE;SANCHEZ GUTIERREZ JAVIER;MORALES...

30/03/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-144228

Nombramientos — 30/03/2017

Nombramientos. Apoderado: AEDAS HOMES SL. Datos registrales. T 33754 , F 144, S 8, H M 607512, I/A 3 (22.03.17).