Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 14 tarjetas
29/11/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-495323

Revocaciones — 29/11/2019

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN MARTIN JOSE MARIA. Apo.Manc.: CAMACHO CALDERON JOAQUIN. Datos registrales. T 25464 , F 198, S 8, H M 166874, I/A 85 (22.11.19).

27/09/2019 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-404833

Cambio de domicilio social — 27/09/2019

Cambio de domicilio social. C/ CONDESA DE VENADITO 7 (MADRID). Datos registrales. T 25464 , F 198, S 8, H M 166874, I/A 84 (19.09.19).

13/08/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-354624

Ceses/dimisiones — 13/08/2019

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GUTIERREZ POZO LEONIDES. Nombramientos. Adm. Solid.: ORTIZ JURADO DAVID ANTONIO. Datos registrales. T 25464 , F 198, S 8, H M 166874, I/A 83 ( 6.08.19).

18/12/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-505782

Nombramientos — 18/12/2018

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ SANCHEZ NATALIA;LOZANO MORILLAS ERNESTO;CASADO FERNANDEZ GONZALO. Apo.Manc.: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GARCIA URUEÑA LUIS ENRIQUE;VENTURA GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO;CAMACHO CALDERON JO...

07/06/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-236835

Revocaciones — 07/06/2017

Revocaciones. Apo.Manc.: ALVAREZ FERNANDEZ SUSANA. Datos registrales. T 25464 , F 196, S 8, H M 166874, I/A 81 (30.05.17).

23/12/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-521857

Revocaciones — 23/12/2016

Revocaciones. Apoderado: REINA GALLARDO ANTONIO. Datos registrales. T 25464 , F 196, S 8, H M 166874, I/A 80 (15.12.16).

04/04/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-146455

Revocaciones — 04/04/2016

Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ GARCIA MARTA. Datos registrales. T 25464 , F 195, S 8, H M 166874, I/A 78 (28.03.16).

23/03/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-134565

Revocaciones — 23/03/2016

Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA URUEÑA LUIS ENRIQUE. Apo.Man.Soli: LOZANO MORILLAS ERNESTO. Apo.Manc.: ALVAREZ FERNANDEZ SUSANA;GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO VENTURA;RODRIGUEZ DOMINGUEZ ROBERTO. Datos registrales. T 25464...

04/12/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-493600

Nombramientos — 04/12/2015

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL POZO MOLINS MARIA JOSE;MARTIN MARTIN JOSE MARIA;LOZANO MORILLAS ERNESTO. Apo.Manc.: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;PALOMO GOMEZ RAFAEL;GARCIA URUEÑA LUIS ENRIQUE;ALVAREZ FERNANDEZ SUSANA;VENT...

24/09/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-387398

Revocaciones — 24/09/2015

Revocaciones. Apoderado: NAHARRO CASTRILLO JOSE MANUEL. Apo.Manc.: ADALID MOLL JOSE LUIS;LACADENA AZPEITIA FERNANDO. Datos registrales. T 25464 , F 192, S 8, H M 166874, I/A 72 (17.09.15).

14/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-287879

Revocaciones — 14/07/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: PENA CACCAMO ANA GABRIELA. Apo.Manc.: CALLEJA MATEO GONZALO. Datos registrales. T 25464 , F 192, S 8, H M 166874, I/A 71 ( 2.07.15).

26/02/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-96983

Revocaciones — 26/02/2013

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DADAMA MACIAS FRANCISCO JAVIER. Apoderado: CASTRO MENAN ELENA. Apo.Man.Soli: DADAMA MACIAS FRANCISCO JAVIER;DADAMA MACIAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 25464 , F 191, S 8, H M 166874...

29/08/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-358765

Revocaciones — 29/08/2012

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MOCHON LOPEZ PABLO. Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA URUEÑA LUIS ENRIQUE. Apo.Man.Soli: DEL POZO MOLINS MARIA JOSE;PENA CACCAMO ANA GABRIELA;VICARIO ORTIZ LAURA;DELGADO MONTERO ALBERTO;DADAMA...

09/02/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-68839

Nombramientos — 09/02/2009

Nombramientos. Apoderado: PASCUAL TORIJA ANGELES;DEL POZO MOLINS MARIA JOSE;PENA CACCAMO ANA GABRIELA;VICARIO ORTIZ LAURA;JODAR CASANOVA MANUEL;DADAMA MACIAS FRANCISCO JAVIER;DOMINGUEZ CORVILLO ARANCHA;ARRIAZA LOUREDA S...