Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 12 tarjetas
28/12/2016 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-526764

Cambio de denominación social — 28/12/2016

Cambio de denominación social. EQUIPOS NUCLEARES SA SME. Datos registrales. T 29802 , F 197, S 8, H M 33892, I/A 344 (19.12.16).

19/10/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-420908

Nombramientos — 19/10/2016

Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29802 , F 197, S 8, H M 33892, I/A 343 (11.10.16).

20/05/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-215231

Revocaciones — 20/05/2016

Revocaciones. Apo.Manc.: ZUBIMENDI ALCORTA JOSE MARIA TEODORO;FAJARDO JIMENA MANUEL. Nombramientos. Apoderado: ZUBIMENDI ALCORTA JOSE MARIA;MATARREDONA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 29802 , F 1...

04/11/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-444731

Nombramientos — 04/11/2015

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SANCHEZ LEANDRO;FERNANDEZ SANCHEZ LEANDRO;MORENO ANGOSTO FERNANDO;BRAGA CUEVA JOSE A;SERRANO BARBA LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 29802 , F 194, S 8, H M 33892, I/A 340 (27.10.15)...

19/10/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-418290

Ceses/dimisiones — 19/10/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 29802 , F 194, S 8, H M 33892, I/A 339 ( 9.10.15).

20/02/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-80970

Nombramientos — 20/02/2014

Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 29802 , F 186, S 8, H M 33892, I/A 333 (13.02.14).

26/11/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-504001

Nombramientos — 26/11/2013

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29802 , F 186, S 8, H M 33892, I/A 330 (18.11.13).

26/11/2013 Sec. I Página web de la sociedad Madrid
Madrid-504002

Página web de la sociedad — 26/11/2013

Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.ensa.es. Datos registrales. T 29802 , F 186, S 8, H M 33892, I/A 331 (18.11.13).

20/03/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-132745

Ceses/dimisiones — 20/03/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: VELASCO GARCIA PALOMA. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ SOMOLINOS GERMAN. Datos registrales. T 29802 , F 175, S 8, H M 33892, I/A 322 (11.03.13).

16/01/2012 Sec. I Desembolso de dividendos pasivos Madrid
Madrid-18559

Desembolso de dividendos pasivos — 16/01/2012

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 7.499.578,50 Euros. Datos registrales. T 24961 , F 45, S 8, H M 33892, I/A 301 ( 2.01.12).

16/03/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-119218

Nombramientos — 16/03/2011

Nombramientos. Consejero: SANCHEZ NARANJO CONSUELO. Datos registrales. T 24961 , F 42, S 8, H M 33892, I/A 296 ( 7.03.11).

16/12/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-523936

Nombramientos — 16/12/2009

Nombramientos. Apoderado: BALLESTEROS PINTO FRANCISCO;ZUBIMENDI ALCORTA JOSE MARIA;ESCAJA CASADO MARIA DEL CARMEN;SIMON ADIEGO JAVIER MARIA;FRASER IAN EDWIN;TRIVIÑO FERNANDEZ RAFAEL. Datos registrales. T 24961 , F 39, S...