Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 11 tarjetas
08/10/2018 Sec. I Otros conceptos: QUEDA DISUELTA LA SOCIEDAD AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA "CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SL" Madrid
Madrid-403774

Otros conceptos: queda disuelta la sociedad al haber sido absorbida por la sociedad domiciliada en madrid, denominada "clear channel espaÑa, sl" — 08/10/2018

Otros conceptos: QUEDA DISUELTA LA SOCIEDAD AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA "CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SL".- Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 32630 , F 49, S 8, H...

23/07/2018 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-304110

Declaración de unipersonalidad — 23/07/2018

Declaración de unipersonalidad. Socio único: CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL. Datos registrales. T 32630 , F 49, S 8, H M 587334, I/A 11 (13.07.18).

24/03/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-133318

Nombramientos — 24/03/2017

Nombramientos. Cons.Del.Sol: HERNANDEZ VALER CESAR;ALMARCHA BARRIOS JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 32630 , F 47, S 8, H M 587334, I/A 10 (15.03.17).

17/01/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-23381

Ceses/dimisiones — 17/01/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: MORALES SANCHEZ JOSE. Co.De.Ma.So: MORALES SANCHEZ JOSE. Consejero: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SL;COLUMBA 2010 SL. Presidente: MORALES SANCHEZ JOSE. SecreNoConsj: GARCIA GONZALEZ IGNACIO. Rep...

16/01/2017 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-20330

Reducción de capital — 16/01/2017

Reducción de capital. Importe reducción: 30.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 663.750,00 Euros. Datos registrales. T 32630 , F 46, S 8, H M 587334, I/A 8 ( 4.01.17).

29/04/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-183387

Ceses/dimisiones — 29/04/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN GARCIA ARISTOBULO. Co.De.Ma.So: JUAN GARCIA ARISTOBULO. Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ VALER CESAR. Datos registrales. T 1411 , F 125, S 8, H CO 13506, I/A 29 (21.04.14).

04/02/2014 Sec. I Nombramientos Córdoba
Córdoba-50694

Nombramientos — 04/02/2014

Nombramientos. Auditor: SANCHEZ JIMENEZ SALVADOR. Aud.Supl.: TRUJILLO FUENTES RAFAEL. Datos registrales. T 1411 , F 125, S 8, H CO 13506, I/A 28 (28.01.14).

29/10/2013 Sec. I Revocaciones Córdoba
Córdoba-461731

Revocaciones — 29/10/2013

Revocaciones. Apo.Sol.: ROLDAN AGUILAR MANUEL LAUREANO. Nombramientos. Apo.Manc.: COLUMBA 2010 SL;GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA;MORALES SANCHEZ JOSE;JUAN GARCIA ARISTOBULO;USALLAN ORTIZ AGUSTIN. Datos registrales. T 1411...

20/06/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-282375

Ceses/dimisiones — 20/06/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA. Nombramientos. Consejero: COLUMBA 2010 SL. Reelecciones. Auditor: VASCO MARTINEZ JOSE MANUEL. Aud.Supl.: GISBERT BARBUDO JOAQUIN. Datos registra...

17/05/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-209179

Ceses/dimisiones — 17/05/2011

Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: GRUPO DE COMUNICACION DEL SUR SL. Consejero: GRUPO DE COMUNICACION DEL SUR SL. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Consejero: CAJA DE AHORROS Y M...

04/01/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-971

Ceses/dimisiones — 04/01/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTIZ CANTERO FRANCISCO JULIAN. Co.De.Ma.So: ORTIZ CANTERO FRANCISCO JULIAN. Nombramientos. Consejero: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA. Datos registrales. T 1411 , F 122, S 8, H CO 13506, I/A 2...