Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 5 tarjetas
08/11/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-462574

Revocaciones — 08/11/2019

Revocaciones. Apoderado: ROTTEMBOURG DAVID;MERIC GILLES LOUIS;MARTINEZ MENENDEZ JAVIER;ESCRIBA GONZALEZ ANTONIO;SERRANO CADAHIA PEDRO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MERIC GILLES LOUIS;ROTTEMBOURG DAVID;MARTINEZ MENENDEZ...

08/11/2019 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-462575

Cambio de domicilio social — 08/11/2019

Cambio de domicilio social. AVDA RITA LEVI MONTALCINI 29 (GETAFE). Datos registrales. T 39614 , F 201, S 8, H M 548282, I/A 11 (31.10.19).

24/04/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-180227

Nombramientos — 24/04/2019

Nombramientos. Presidente: ROTTEMBOURG DAVID. Vicepresid.: MARTINEZ MENENDEZ JAVIER. Secretario: EZQUERRA APRAIZ JAVIER. Apoderado: ROTTEMBOURG DAVID;MERIC GILLES LOUIS;MARTINEZ MENENDEZ JAVIER;ESCRIBA GONZALEZ ANTONIO;...

27/03/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-137898

Ceses/dimisiones — 27/03/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTES TESTILLANO VICENTE. Vicepresid.: CORTES TESTILLANO VICENTE. Consejero: NICOLAIDES KYPRIANOS. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ MENENDEZ JAVIER. Datos registrales. T 30467 , F 35, S 8...

18/07/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-297898

Ceses/dimisiones — 18/07/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARDIN DENIS;BEGEY SYLVIE. Presidente: GARDIN DENIS. Nombramientos. Consejero: ROTTEMBOURG DAVID;MERIC GILLES LOUIS;NICOLAIDES KYPRIANOS. Datos registrales. T 30467 , F 35, S 8, H M 548282,...