Actos destacados
Transformación de sociedad — 14/06/2019
Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA. Nombramientos. Representan: PAREJO DEL RIO DANIEL;GIMENEZ SORIANO PABLO;ASUERO RESUSTA VICENTE. Reelecciones. Consejero: VE HOLDCO...
Ceses/dimisiones — 10/04/2019
Ceses/Dimisiones. Secretario: CIEZA PERAL PEDRO. Vicesecret.: BLASCO FILLOL SERGIO. Nombramientos. SecreNoConsj: VAZQUEZ DEL REY VILLANUEVA RAMON NICOLAS. VsecrNoConsj: BARDIN RODRIGUEZ-LOSADA BLANCA. Datos registrales....
Revocaciones — 20/02/2019
Revocaciones. Apo.Manc.: O'FLAHERTY PETER. Nombramientos. Apoderado: PEREZ MARCOS OSCAR;ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZ SORIANO PABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL;SAAVEDRA RODRIGUEZ DEL PALACIO PABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL. Dato...
Ceses/dimisiones — 19/02/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: O'FLAHERTY PETER. Nombramientos. Consejero: SAAVEDRA RODRIGUEZ DEL PALACIO PABLO. Datos registrales. T 38718 , F 30, S 8, H M 688414, I/A 3 (12.02.19).
Cambio de domicilio social — 18/02/2019
Cambio de domicilio social. C/ JENNER 3 4 (MADRID). Datos registrales. T 38718 , F 30, S 8, H M 688414, I/A 2 (11.02.19).
Ceses/dimisiones — 09/01/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALDESA CONTRUCCIONES SA. Presidente: ALDESA CONTRUCCIONES SA. Consejero: ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA. Vicepresid.: ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA. Consejero: DIF MANAGEMENT FRANCE SAR...
Nombramientos — 09/01/2019
Nombramientos. Apo.Manc.: OLAGUIBEL AMICH IÑIGO;VALENCIA MUÑOZ PABLO;ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZ SORIANO PABLO;PAREJO DEL RIO DANIEL;PEREZ OSCAR. Datos registrales. T 6234 , F 173, S 8, H SE 68975, I/A 32 (27.12.18).
Otros conceptos: extendida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a madrid — 09/01/2019
Otros conceptos: Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a MADRID.- D...
Revocaciones — 23/04/2018
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNADEZ RUIZ ALEJANDRO;NUÑEZ MORENO FELIX;VAN DER GEES JORIS ALBERT JAN;PLAZA BARANDA JORGE;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: NUÑEZ MORENO FELIX;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIG...
Ceses/dimisiones — 05/09/2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: O'FLAHERTY PETER. Nombramientos. Secretario: CIEZA PERAL PEDRO. Vicesecret.: BLASCO FILLOL SERGIO. Datos registrales. T 6234 , F 171, S 8, H SE 68975, I/A 29 (21.08.17).
Reducción de capital — 14/02/2017
Reducción de capital. Importe reducción: 14.064.827,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.010,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 6234 , F 170, S 8, H S...
Nombramientos — 19/01/2017
Nombramientos. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 6234 , F 170, S 8, H SE 68975, I/A 27 (11.01.17).
Otros conceptos: "aldesa construcciones, s — 12/09/2016
Otros conceptos: "ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A." cesa a don Alejandro Fernández Ruiz como persona física y nombra a don Miguel López de Foronda Pérez, como nueva persona fisica representante en el Consejo de Administració...
Revocaciones — 10/08/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: HILLA MERCHAN GUILLERMO;HILLA MERCHAN GUILLERMO. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ BENITEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 5298 , F 225, S 8, H SE 68975, I/A 25 ( 3.08.16).
Revocaciones — 11/07/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: BLANC GARCIA VALCARCEL CARLOS. Datos registrales. T 5298 , F 225, S 8, H SE 68975, I/A 24 (27.06.16).
Nombramientos — 11/11/2015
Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5298 , F 224, S 8, H SE 68975, I/A 23 (30.10.15).
Nombramientos — 05/11/2015
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5298 , F 224, S 8, H SE 68975, I/A 22 (28.10.15).
Ceses/dimisiones — 07/07/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV. Nombramientos. Consejero: DIF MANAGEMENT FRANCE SARL. Datos registrales. T 5298 , F 223, S 8, H SE 68975, I/A 20 (27.06.14).
Nombramientos — 08/03/2013
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5298 , F 223, S 8, H SE 68975, I/A 19 (26.02.13).
Ceses/dimisiones — 24/01/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN DER GEEST JORIS ALBERT. Vicesecret.: VAN DER GEEST JORIS ALBERT. Secretario: RUIJS EDUARD. Consejero: RUIJS EDUARD. Revocaciones. Apo.Sol.: RUIJS EDUARD;SALVADOR PENDON JUAN;HERNANDEZ DU...
Revocaciones — 28/05/2010
Revocaciones. Apoderado: DOMINGO VARONA JUAN CARLOS. Apo.Sol.: FERNANDEZ RUIZ ISABEL;FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Apoderado: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO;MATANZO CABALLERO FRANCISCO JAVIER;GARCIA NATES MIGUEL;FERNANDEZ...
Pérdida del caracter de unipersonalidad — 28/04/2010
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO;MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO;NUÑEZ MORENO FELIX. Secretario: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO. Presidente: FERNANDEZ R...
Revocaciones — 05/02/2010
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ NAVARRO GONZALO. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA VALCARCEL CARLOS. Datos registrales. T 5023 , F 74, S 8, H SE 68975, I/A 10 (21.12.09).