Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 22 tarjetas
27/07/2016 Sec. I Reelecciones A Coruña
A Coruña-309675

Reelecciones — 27/07/2016

Reelecciones. Consejero: BUEY CASAUS EDUARDO. Datos registrales. T 2846 , F 223, S 8, H C 21269, I/A 49 (14.07.16).

07/12/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-495540

Ceses/dimisiones — 07/12/2015

Ceses/Dimisiones. Secretario: ALCANTARA BRAVO MARIA MACARENA. Nombramientos. Secretario: CEPEDA MORRAS JAVIER. Datos registrales. T 2846 , F 222, S 8, H C 21269, I/A 47 (30.11.15).

13/10/2015 Sec. I Reelecciones A Coruña
A Coruña-409339

Reelecciones — 13/10/2015

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2846 , F 221, S 8, H C 21269, I/A 44 ( 5.10.15).

13/10/2015 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-409340

Revocaciones — 13/10/2015

Revocaciones. Apo.Sol.: SERRANO PATZIG JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: PERIS CAMINERO ANA-MARIA. Datos registrales. T 2846 , F 222, S 8, H C 21269, I/A 45 ( 5.10.15).

14/09/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-373862

Ceses/dimisiones — 14/09/2015

Ceses/Dimisiones. Secretario: DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA JAVIER. Consejero: GUERRA REHN DAVID;SERRATO VALLEJO RAFAEL;SERRANO PATZIG JAVIER. Presidente: SERRANO PATZIG JAVIER. Nombramientos. Consejero: DE LA CUADRA MO...

14/09/2015 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-373863

Revocaciones — 14/09/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GALLART GABAS ANTONIO. Apo.Sol.: GUERRA REHN DAVID. Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA CUADRA MOYA JOSE LUIS. Datos registrales. T 2846 , F 221, S 8, H C 21269, I/A 43 ( 4.09.15).

22/05/2015 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-206867

Nombramientos — 22/05/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA JAVIER;BARRIONUEVO HUELAMO MARTA. Datos registrales. T 2846 , F 220, S 8, H C 21269, I/A 41 (12.05.15).

08/08/2014 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-327072

Nombramientos — 08/08/2014

Nombramientos. Apoderado: FELIP FONT JOAN. Datos registrales. T 2846 , F 220, S 8, H C 21269, I/A 39 ( 1.08.14).

08/08/2014 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-327073

Nombramientos — 08/08/2014

Nombramientos. Apoderado: JUAN FERRER ROSA. Datos registrales. T 2846 , F 220, S 8, H C 21269, I/A 40 ( 1.08.14).

23/01/2014 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-30550

Nombramientos — 23/01/2014

Nombramientos. Apo.Sol.: DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA JAVIER;LUNA RODRIGUEZ IÑIGO. Datos registrales. T 2846 , F 219, S 8, H C 21269, I/A 37 (16.01.14).

05/08/2013 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-349221

Revocaciones — 05/08/2013

Revocaciones. Apo.Sol.: DACOSTA LOPEZ JORGE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: LANDEIRA SUAREZ MARIA. Datos registrales. T 2846 , F 219, S 8, H C 21269, I/A 35 (30.07.13).

28/01/2013 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-41689

Nombramientos — 28/01/2013

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2846 , F 219, S 8, H C 21269, I/A 33 (21.01.13).

12/04/2012 Sec. I Reelecciones A Coruña
A Coruña-163850

Reelecciones — 12/04/2012

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2846 , F 218, S 8, H C 21269, I/A 31 ( 2.04.12).

14/11/2011 Sec. I Modificaciones estatutarias A Coruña
A Coruña-449186

Modificaciones estatutarias — 14/11/2011

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 4º: Relativo al DOMICILIO SOCIAL.- . Cambio de domicilio social. AVDA DE ARTEIXO 171 (CORUÑA (A)). Datos registrales. T 2846 , F 218, S 8, H C 21269, I/A...

27/10/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-425920

Ceses/dimisiones — 27/10/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ ZAMORA ANTONIO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Presidente: GOMEZ ZAMORA ANTONIO. Consejero: MUÑOZ GONZALEZ-ALBO JUAN MANUEL. Nombramientos. Consejero: GUERRA REHN DAVID;SERRATO VALLEJO RAFA...

27/10/2011 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-425921

Revocaciones — 27/10/2011

Revocaciones. Apo.Sol.: LOZANO PUEYO EPIFANIO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;MUÑOZ GONZALEZ-ALBO JUAN MANUEL.Apo.Manc.: GOMEZ ZAMORA ANTONIO;DOMINGUEZ RUBIRA SANTIAGO. Apoderado: LOZANO PUEYO EPIFANIO. Datos registrales. T 2...

06/10/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-398330

Ceses/dimisiones — 06/10/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ RUBIRA SANTIAGO. Secretario: BERENGUER GOMEZ VIRGINIA. Nombramientos. Consejero: BUEY CASAUS EDUARDO. Secretario: DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA JAVIER. Datos registrales. T 2846 ,...

03/03/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-96618

Ceses/dimisiones — 03/03/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: IGLESIA LACHICA LEOPOLDO;LLORENTE GOMEZ EUGENIO. Nombramientos. Consejero: GOMEZ ZAMORA ANTONIO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 2803 , F 91, S 8, H C 21269, I/A 23 (23.02.11)...

03/02/2011 Sec. I Reelecciones A Coruña
A Coruña-46796

Reelecciones — 03/02/2011

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2803 , F 91, S 8, H C 21269, I/A 22 (26.01.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 23 Jueves 3 de febrero de 2011 Pág. 5979 cve: BORME-A-2011-23-15

02/06/2010 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-219840

Nombramientos — 02/06/2010

Nombramientos. Consejero: GARCIA ALTOZANO ANGEL. Presidente: GARCIA ALTOZANO ANGEL. Consejero: LLORENTE GOMEZ EUGENIO. Datos registrales. T 2803 , F 90, S 8, H C 21269, I/A 20 (24.05.10).

02/06/2010 Sec. I Reelecciones A Coruña
A Coruña-219841

Reelecciones — 02/06/2010

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2803 , F 90, S 8, H C 21269, I/A 21 (24.05.10).

08/02/2010 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos A Coruña
A Coruña-52241

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 08/02/2010

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GARCIA ALTOZANO ANGEL. Presidente: GARCIA ALTOZANO ANGEL. Consejero: LLORENTE GOMEZ EUGENIO. Datos registrales. T 2199 , F 38, S 8, H C 21269, I/A 11 (28.01.10). BOLE...