Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 7 tarjetas
30/12/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-529937

Ceses/dimisiones — 30/12/2015

Ceses/Dimisiones. Representan: CUEVAS MORENO PEDRO JESUS. Adm. Unico: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA. Revocaciones. Apoderado: AGUIRRE DIAZ GUARDAMINO ALFONSO;LOZANO PUEYO EPIFANIO;LLORENTE GOMEZ EUGENIO BARTOLOME;L...

24/12/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-523108

Nombramientos — 24/12/2015

Nombramientos. Apoderado: LOZANO PUEYO EPIFANIO. Datos registrales. T 21657 , F 197, S 8, H M 195872, I/A 66 (16.12.15).

24/02/2014 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-84897

Reelecciones — 24/02/2014

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 21657 , F 196, S 8, H M 195872, I/A 63 (13.02.14).

18/12/2013 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-540456

Cambio de domicilio social — 18/12/2013

Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 10 (MADRID). Datos registrales. T 21657 , F 196, S 8, H M 195872, I/A 62 (10.12.13).

21/01/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-28452

Revocaciones — 21/01/2013

Revocaciones. Apoderado: DEL CAMPO MAESTRO MUÑOZ MONICO. Datos registrales. T 21657 , F 195, S 8, H M 195872, I/A 60 (11.01.13).

07/11/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-457203

Revocaciones — 07/11/2012

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ TRESGALLO GUSTAVO ADOLFO;GARCIA ARENAL RODRIGUEZ PABLO. Datos registrales. T 21657 , F 194, S 8, H M 195872, I/A 56 (24.10.12).

28/04/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-198066

Nombramientos — 28/04/2009

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ZAMORA ANTONIO. Datos registrales. T 21657 , F 187, S 8, H M 195872, I/A 41 (15.04.09).