Actos destacados
Ceses/dimisiones — 05/05/2016
Ceses/Dimisiones. Liquidador M: LILLO LOPEZ-SALAZAR ALBERTO;GONZALEZ-ALBO MORALES JOSE. Nombramientos. Consejero: CAMACHO AYUSO SATURNINO;FERNANDEZ MORALES JORGE;MARTINEZ ARCOS SARA SUSANA;SERRANO DE LA MOÑAZA ARCOS DAV...
Reelecciones — 18/02/2014
Reelecciones. Auditor: AUDIT PROCESS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 524 , F 201, S 8, H CR 15373, I/A 32 (10.02.14).
Ceses/dimisiones — 27/08/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: VELADO GUILLEN EMILIO. Vicepresid.: MARTIN CAMACHO PEDRO ANTONIO. Consejero: ROMERO SANCHEZ ROSA. Presidente: ROMERO SANCHEZ ROSA. Nombramientos. Consejero: MERINO CHACON MARIA DOLORES. Pres...
Ceses/dimisiones — 27/08/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: FUENTES PASTRANA JOSE. Nombramientos. Consejero: LILLO LOPEZ-SALAZAR ALBERTO. Datos registrales. T 524 , F 201, S 8, H CR 15373, I/A 31 (20.08.13).
Ceses/dimisiones — 26/03/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Vicepresid.: CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Revocaciones. Apo.Sol.: CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: MARTIN CAMACHO PEDRO ANTONIO. Vicepresid...
Ceses/dimisiones — 28/12/2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: ROMERO SANCHEZ ROSA. Consejero: ROMERO SANCHEZ ROSA;CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Vicepresid.: CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Consejero: RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL;AGUIRRE MORENO TERESA;C...
Nombramientos — 28/12/2011
Nombramientos. Presidente: ROMERO SANCHEZ ROSA. Vicepresid.: CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Reelecciones. Secretario: GONZALEZ-ALBO MORALES JOSE. Datos registrales. T 524 , F 198, S 8, H CR 15373, I/A 26 (29.11.11).
Revocaciones — 28/12/2011
Revocaciones. Apoderado: ROMERO SANCHEZ ROSA;CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO SANCHEZ ROSA;CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 524 , F 199, S 8, H CR 15373, I/A 27º (29.11.11).
Ampliación de capital — 17/03/2011
Ampliación de capital. Capital: 1.377.282,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.320.408,00 Euros. Datos registrales. T 448 , F 225, S 8, H CR 15373, I/A 24 ( 1.03.11).
Revocaciones — 15/11/2010
Revocaciones. Apoderado: GIL ORTEGA RINCON FRANCISCO;PARIENTE MUÑOZ JOSE GUILLERMO. Datos registrales. T 448 , F 225, S 8, H CR 15373, I/A 23 (22.10.10).
Reelecciones — 11/10/2010
Reelecciones. Auditor: AUDIT PROCESS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 448 , F 225, S 8, H CR 15373, I/A 22 (21.09.10).
Otros conceptos: se da nueva redacción a los artículos 1º y 2º de los estatutos sociales, referentes a la denominación de la sociedad y el objeto social — 28/04/2010
Otros conceptos: Se da nueva redacción a los Artículos 1º y 2º de los Estatutos Sociales, referentes a la denominación de la sociedad y el objeto social. Datos registrales. T 448 , F 224, S 8, H CR 15373, I/A 21 (13.04....
Ampliación de capital — 07/04/2010
Ampliación de capital. Capital: 1.134.294,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.943.126,00 Euros. Datos registrales. T 448 , F 223, S 8, H CR 15373, I/A 20 ( 3.03.10).
Ceses/dimisiones — 04/03/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: PARIENTE MUÑOZ JOSE GUILLERMO;JERONIMO DE PAZ MARIA DE LOS ANGELES. Nombramientos. Consejero: ESPINOSA ROMERO AGUSTIN;GARRIDO GARRANCHO RAIMUNDO. Datos registrales. T 448 , F 223, S 8, H CR...
Nombramientos — 27/11/2009
Nombramientos. Apoderado: CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 448 , F 222, S 8, H CR 15373, I/A 17 (14.11.09).
Nombramientos — 27/11/2009
Nombramientos. Apoderado: VALIENTE MORENO MARCELO. Datos registrales. T 448 , F 222, S 8, H CR 15373, I/A 18 (14.11.09).