Actos destacados
Ceses/dimisiones — 16/06/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: SESTAYO DOCE BEATRIZ;DIAZ DOCE BRUNO JOSE. Nombramientos. Consejero: BASTERRECHEA LOPEZ JESUS;MONTES CELEIRO JOSE ALVARO. Datos registrales. T 3520 , F 171, S 8, H C 24574, I/A 68 ( 8.06.17).
Revocaciones — 16/06/2017
Revocaciones. Apo.Manc.: DIAZ DOCE BRUNO JOSE;FREIRE FAJARDO MARIA EUGENIA;SESTAYO DOCE BEATRIZ. Nombramientos. Apo.Manc.: VICTORIA GALLEGO LUIS MIGUEL;MONTES CELEIRO JOSE ALVARO;BASTERRECHEA LOPEZ JESUS;PISA JARABA ALE...
Revocaciones — 16/06/2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ SOLLA GONZALEZ JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ GALLARDO RAFAEL. Datos registrales. T 3520 , F 172, S 8, H C 24574, I/A 70 ( 8.06.17).
Revocaciones — 16/06/2017
Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ DOCE BRUNO JOSE;FREIRE FAJARDO MARIA EUGENIA;SESTAYO DOCE BEATRIZ. Nombramientos. Apo.Sol.: VICTORIA GALLEGO LUIS MIGUEL;MONTES CELEIRO JOSE ALVARO;BASTERRECHEA LOPEZ JESUS Datos registrales...
Articulo 378 — 12/06/2017
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3520 , F 171, S 8, H C 24574,...
Articulo 378 — 12/06/2017
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3520 , F 171, S 8, H C 24574,...
Ceses/dimisiones — 30/03/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO HERREROS SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: PARRA DIAZ DIEGO. Datos registrales. T 3520 , F 170, S 8, H C 24574, I/A 65 (23.03.17).
Ceses/dimisiones — 09/01/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FREIRE FAJARDO MARIA EUGENIA. Nombramientos. Consejero: VICTORIA GALLEGO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 3520 , F 170, S 8, H C 24574, I/A 64 (28.12.16).
Articulo 378 — 13/12/2016
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3520 , F 170, S 8, H C 24574,...
Articulo 378 — 13/12/2016
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3520 , F 170, S 8, H C 24574,...
Articulo 378 — 04/05/2016
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3520 , F 170, S 8, H C 24574,...
Articulo 378 — 21/10/2015
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3181 , F 108, S 8, H C 24574,...
Ceses/dimisiones — 21/10/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: REY VARELA JOSE MANUEL;LANGTRY CAINZOS ALEJANDRO. Presidente: REY VARELA JOSE MANUEL. Consejero: FERNANDEZ GARCIA JUAN JOSE;CARRO MUÑOZ BORJA. Nombramientos. Consejero: SUAREZ FERNANDEZ JORG...
Nombramientos — 21/10/2015
Nombramientos. Presidente: SUAREZ FERNANDEZ JORGE JUAN. Datos registrales. T 3181 , F 108, S 8, H C 24574, I/A 57 (15.10.15).
Nombramientos — 21/10/2015
Nombramientos. Consejero: SESTAYO DOCE BEATRIZ. Datos registrales. T 3181 , F 109, S 8, H C 24574, I/A 58 (15.10.15).
Revocaciones — 21/10/2015
Revocaciones. Apo.Manc.: REY VARELA JOSE MANUEL;LANGTRY CAINZOS ALEJANDRO;FERNANDEZ GARCIA JUAN JOSE;PISA JARABA ALEJANDRO;CARRO MUÑOZ BORJA;PISA JARABA ALEJANDRO. Nombramientos. Apo.Manc.: SUAREZ FERNANDEZ JORGE JUAN;D...
Revocaciones — 21/10/2015
Revocaciones. Apo.Sol.: REY VARELA JOSE MANUEL;LANGTRY CAINZOS ALEJANDRO;FERNANDEZ GARCIA JUAN JOSE;CARRO MUÑOZ BORJA. Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ FERNANDEZ JORGE JUAN;DIAZ DOCE BRUNO JOSE;FREIRE FAJARDO MARIA EUGEN...
Nombramientos — 26/06/2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ SOLLA GONZALEZ JESUS. Datos registrales. T 3181 , F 107, S 8, H C 24574, I/A 54 (22.06.15).
Reelecciones — 11/09/2014
Reelecciones. Auditor: AUDIGAL SL. Datos registrales. T 3181 , F 107, S 8, H C 24574, I/A 53 ( 4.09.14).
Revocaciones — 10/07/2014
Revocaciones. Apo.Manc.: CAL MARTINEZ CASIMIRO PABLO. Nombramientos. Apo.Manc.: CARRO MUÑOZ BORJA;PISA JARABA ALEJANDRO. Datos registrales. T 3181 , F 106, S 8, H C 24574, I/A 52 ( 3.07.14).
Ceses/dimisiones — 09/06/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAL MARTINEZ CASIMIRO PABLO. Nombramientos. Consejero: CARRO MUÑOZ BORJA. Datos registrales. T 3181 , F 106, S 8, H C 24574, I/A 50 (30.05.14).
Revocaciones — 09/06/2014
Revocaciones. Apo.Sol.: CAL MARTINEZ CASIMIRO PABLO. Nombramientos. Apo.Sol.: CARRO MUÑOZ BORJA. Datos registrales. T 3181 , F 106, S 8, H C 24574, I/A 51 (30.05.14).
Articulo 378 — 09/03/2012
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2009 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3181 , F 105, S 8, H C 24574,...
Articulo 378 — 09/03/2012
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2010 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3181 , F 105, S 8, H C 24574,...