Actos destacados
Nombramientos — 27/07/2016
Nombramientos. Apoderado: AVE SOUTO RAFAEL. Datos registrales. T 1751 , F 56, S 8, H C 11968, I/A 15 (20.07.16).
Revocaciones — 19/05/2016
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DIZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 1754 , F 56, S 8, H C 11968, I/A 14 (11.05.16).
Nombramientos — 25/11/2015
Nombramientos. Apoderado: AVE SOUTO RAFAEL. Datos registrales. T 1521 , F 46, S 8, H C 11968, I/A 13 (16.11.15).
Nombramientos — 23/10/2015
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DIZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 1521 , F 46, S 8, H C 11968, I/A 12 (16.10.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Viernes 23 de octubre de 2015 Pág. 46089 cve: BORME...
Revocaciones — 11/06/2015
Revocaciones. Apoderado: FONT MOLEJON JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1521 , F 46, S 8, H C 11968, I/A 10 (29.05.15).
Nombramientos — 11/06/2015
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 1521 , F 46, S 8, H C 11968, I/A 11 (29.05.15).
Modificaciones estatutarias — 21/09/2011
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: RELATIVO AL DOMICILIO SOCIAL.-. Cambio de domicilio social. C/ VULCANO 1 BAJO - POLIGONO DE ICARIA III (OLEIROS). Datos registrales. T 1521 , F 45, S 8, H C 11968,...