Actos destacados
Reducción de capital — 08/02/2017
Reducción de capital. Importe reducción: 11.927.548,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.720.987,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social. Datos registrales. T 3320 ,...
Nombramientos — 22/12/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ TELLO ANTONIO. Apoderado: MENENDEZ BERNARDO MANUEL. Datos registrales. T 3320 , F 122, S 8, H C 44123, I/A 61 (15.12.16).
Nombramientos — 04/05/2016
Nombramientos. Auditor: AUDIT 3 SA. Datos registrales. T 3320 , F 121, S 8, H C 44123, I/A 58 (25.04.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 84 Miércoles 4 de mayo de 2016 Pág. 20590 cve: BORME-A-2016-84-15
Revocaciones — 04/05/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;MARTIN CASTELLO FELIX. Apo.Man.Soli: GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE DEMETRIO. Apo.Sol.: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;RUIZ DE CAST...
Revocaciones — 21/03/2016
Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ TELLO ANTONIO;SANCHEZ TELLO ANTONIO. Datos registrales. T 3320 , F 121, S 8, H C 44123, I/A 55 (11.03.16).
Revocaciones — 21/03/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: SAGASTIZABAL CARDELUS ALFONSO MARIA. Datos registrales. T 3320 , F 121, S 8, H C 44123, I/A 56 (11.03.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 55 Lunes 21 de marzo de 2016 Pág. 13744 cve:...
Revocaciones — 21/03/2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Apo.Manc.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER. Datos registrales. T...
Fe de erratas: publicado por error el nombamiento de soil recovery sl como administrador mancomunado cuando es administrador unico — 17/12/2015
Fe de erratas: Publicado por error el nombamiento de SOIL RECOVERY SL como Administrador mancomunado cuando es ADMINISTRADOR UNICO. Datos registrales. T 3320 , F 117, S 8, H C 44123, I/A 47 (11.11.15).
Ampliación de capital — 17/12/2015
Ampliación de capital. Capital: 580.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.648.535,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social. Datos registrales. T 3320 , F 120, S 8,...
Revocaciones — 25/11/2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBIN IGLESIAS PEDRO ANGEL. Datos registrales. T 3320 , F 117, S 8, H C 44123, I/A 48 (17.11.15).
Revocaciones — 25/11/2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;MORENO ALVAREZ LUIS;GARCIA-ZARANDIETA GIMENEZ ANTONIO JUAN. Apo.Manc.: CRUZ CRUZ BEGOÑA. Apo.Sol.: MIGUEL GONZALEZ LUIS ESTEBAN;MARTIN FRANCISCO DAMIAN DOROTEO;FOJO...
Revocaciones — 25/11/2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;DE EGAÑA HUERTA ALFONSO MIGUEL;DE ISIDRO SERRANO JESUS ANTONIO;VILLACAÑAS BEADES ANA;PIRE ABARCA FERNAN...
Reducción de capital — 25/11/2015
Reducción de capital. Importe reducción: 31.919.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 16.758.535,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: CAPITAL SOCIAL.-. Datos registrales. T 3320 , F 120, S 8, H...
Ampliación de capital — 25/11/2015
Ampliación de capital. Capital: 7.310.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.068.535,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: CAPITAL SOCIAL.-. Datos registrales. T 3320 , F 120, S 8, H C 44123,...
Sociedad unipersonal — 19/11/2015
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SOIL RECOVERY SL. Ceses/Dimisiones. Secretario: ATIENZA LA ORDEN JORGE. Consejero: REINA PINTO JUAN CARLOS;LORENZO FERNANDEZ RAFAEL;BARREIRO NOGALEGO ENRIQUE. P...
Ceses/dimisiones — 11/11/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ TORRALBO ANTONIO. Presidente: GONZALEZ TORRALBO ANTONIO. Nombramientos. Consejero: BARREIRO NOGALEGO ENRIQUE. Presidente: BARREIRO NOGALEGO ENRIQUE. Datos registrales. T 3320 , F 11...
Revocaciones — 25/05/2015
Revocaciones. Apo.Manc.: VALENZUELA CONTRERAS COSME. Datos registrales. T 3320 , F 116, S 8, H C 44123, I/A 42 (18.05.15).
Revocaciones — 25/05/2015
Revocaciones. Apo.Manc.: VALENZUELA CONTRERAS COSME. Datos registrales. T 3320 , F 116, S 8, H C 44123, I/A 43 (18.05.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 96 Lunes 25 de mayo de 2015 Pág. 22717 cve: BORME-A-...
Revocaciones — 25/05/2015
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 3320 , F 116, S 8, H C 44123, I/A 44 (18.05.15).
Ceses/dimisiones — 25/05/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Nombramientos. Consejero: LORENZO FERNANDEZ RAFAEL. Datos registrales. T 3320 , F 116, S 8, H C 44123, I/A 45 (18.05.15).
Reelecciones — 11/03/2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3320 , F 115, S 8, H C 44123, I/A 40 (27.02.15).
Nombramientos — 11/03/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: BENITO RICHARD DAVID;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3320 , F 116, S 8, H C 44123, I/A 41 (27.02.15).
Revocaciones — 11/03/2014
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ DURAN BARBARA. Datos registrales. T 3320 , F 115, S 8, H C 44123, I/A 37 ( 3.03.14).
Reelecciones — 02/12/2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3320 , F 115, S 8, H C 44123, I/A 36 (25.11.13).