Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2026 7 tarjetas
23/04/2026 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-197685

Revocaciones — 23/04/2026

Revocaciones. Apoderado: TABANELLI MARCELLA. Nombramientos. Apo.Sol.: SIDHU RAVINDER. Datos registrales. S 8 , H M 286819, I/A 24 (16.04.26).

23/04/2026 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-197686

Cambio de domicilio social — 23/04/2026

Cambio de domicilio social. C/ ESPRONCEDA 40 (MADRID). Datos registrales. S 8 , H M 286819, I/A 25 (16.04.26).

23/07/2015 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-304527

Cambio de domicilio social — 23/07/2015

Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR FLEMING 3 4& (MADRID). Datos registrales. T 16788 , F 209, S 8, H M 286819, I/A 17 (14.07.15).

23/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-304528

Nombramientos — 23/07/2015

Nombramientos. Apoderado: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;PEREZ SERRANO ISABEL;PEREZ MANSILLA DELGADO PATRICIA;MEE ANDREW DAVID;SIDHU RAVINDER SINGH;CSAPO JOHN FRANK. Datos registrales....

23/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-304529

Revocaciones — 23/07/2015

Revocaciones. Apoderado: MEE ANDREW DAVID;JOHNSON ANDREW GRAEME;VINCENT EMMA PATRICIA. Datos registrales. T 16788 , F 210, S 8, H M 286819, I/A 19 (15.07.15).

11/10/2012 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-416562

Reelecciones — 11/10/2012

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16788 , F 84, S 8, H M 286819, I/A 12 ( 2.10.12).

28/08/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-357344

Revocaciones — 28/08/2012

Revocaciones. Apoderado: VON BECKH ISABEL;VON BECKH ISABEL;VON BECKH ISABEL. Datos registrales. T 16788 , F 84, S 8, H M 286819, I/A 10 (17.08.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 164 Martes 28 de agosto de...