Actos destacados
Ceses/dimisiones — 02/08/2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CACHO VICENTE LUIS IGNACIO. Nombramientos. Consejero: TEMPRANO LATORRE MIGUEL ANGEL;MERA LATAS ANA;CACHO VICENTE MARIA CARMEN. Presidente: TEMPRANO LATORRE MIGUEL ANGEL. SecreNoConsj: ALTUZ...
Cambio de domicilio social — 13/08/2015
Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 53 2º - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 33663 , F 44, S 8, H M 605941, I/A 2 ( 5.08.15).
Nombramientos — 17/11/2014
Nombramientos. Apoderado: PEREZ TEMPRANO JAVIER. Datos registrales. T 516 , F 194, S 8, H LO 8124, I/A 21 (10.11.14).
Nombramientos — 23/10/2014
Nombramientos. Apoderado: TEMPRANO LATORRE MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 513 , F 224, S 8, H LO 8124, I/A 20 (17.10.14).
Nombramientos — 16/04/2014
Nombramientos. Apoderado: TEMPRANO LATORRE MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 513 , F 224, S 8, H LO 8124, I/A 19 ( 9.04.14).
Revocaciones — 25/03/2014
Revocaciones. Apoderado: PLAZA MARINA BEATRIZ;GONZALEZ LOPEZ DE MURILLAS FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 513 , F 224, S 8, H LO 8124, I/A 18 (18.03.14). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L....
Revocaciones — 05/02/2014
Revocaciones. Apoderado: SAENZ BARRIO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 513 , F 224, S 8, H LO 8124, I/A 17 (29.01.14).
Nombramientos — 25/11/2013
Nombramientos. Apoderado: ALTUZARRA MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 513 , F 223, S 8, H LO 8124, I/A 16 (18.11.13).
Nombramientos — 07/11/2013
Nombramientos. Apoderado: ALTUZARRA MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 513 , F 223, S 8, H LO 8124, I/A 15 (30.10.13).
Reducción de capital — 17/05/2013
Reducción de capital. Importe reducción: 515.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliación de capital. Capital: 903.804,00 Euros. Resultante Suscrito: 903.804,00 Euros. Datos registrales. T 513 , F 222, S 8,...
Revocaciones — 21/09/2011
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ GUTIERREZ PEDRO. Datos registrales. T 513 , F 222, S 8, H LO 8124, I/A 13 (12.09.11).
Nombramientos — 20/07/2011
Nombramientos. Apoderado: SAENZ BARRIO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 513 , F 221, S 8, H LO 8124, I/A 12 (11.07.11).
Nombramientos — 26/05/2011
Nombramientos. Apoderado: TEMPRANO LATORRE MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 513 , F 221, S 8, H LO 8124, I/A 11 (17.05.11).
Nombramientos — 07/04/2011
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GUTIERREZ PEDRO. Datos registrales. T 513 , F 220, S 8, H LO 8124, I/A 10 (29.03.11).
Revocaciones — 14/02/2011
Revocaciones. Apoderado: MAÑAS DE HUELBES MANUEL FELIX. Datos registrales. T 513 , F 221, S 8, H LO 8124, I/A 9 ( 3.02.11).
Ampliación de capital — 10/02/2010
Ampliación de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 515.200,00 Euros. Datos registrales. T 513 , F 220, S 8, H LO 8124, I/A 8 ( 1.02.10).
Cambio de domicilio social — 30/11/2009
Cambio de domicilio social. C/ PIQUERAS 31 5& (LOGROÑO). Datos registrales. T 513 , F 219, S 8, H LO 8124, I/A 7 (19.11.09).
Nombramientos — 04/06/2009
Nombramientos. Apoderado: MAÑAS DE HUELBES MANUEL FELIX. Datos registrales. T 513 , F 219, S 8, H LO 8124, I/A 6 (25.05.09).