Actos destacados
Nombramientos — 24/01/2019
Nombramientos. Auditor: RCM AUDITORES SL. Datos registrales. T 1146 , F 71, S 8, H L 22750, I/A 12 (16.01.19).
Nombramientos — 21/11/2017
Nombramientos. Apoderado: VIDAL SUAREZ CARLOS. Datos registrales. T 1146 , F 71, S 8, H L 22750, I/A 11 (14.11.17). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Ceses/dimisiones — 22/08/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS;VIDAL SUAREZ CARLOS;RIBES COIT SEBASTIAN. Presidente: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA. Cons.Del.Man: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS...
Reelecciones — 26/04/2016
Reelecciones. Auditor: PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 1146 , F 70, S 8, H L 22750, I/A 9 (19.04.16).
Reelecciones — 10/06/2013
Reelecciones. Auditor: PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 1146 , F 70, S 8, H L 22750, I/A 8 ( 3.06.13).
Ceses/dimisiones — 07/02/2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: CASTELLS FARRAS JOAN. Cons.Del.Man: CASTELLS FARRAS JOAN;NADAL CLARET EDUARDO. Vicepresid.: VIDAL SUAREZ CARLOS. Cons.Del.Man: VIDAL SUAREZ CARLOS;RIBES COIT SEBASTIAN. Nombramientos. Conse...
Cambio de domicilio social — 07/04/2010
Cambio de domicilio social. PLAZA DE L'ENSENYANCA 1 BAJOS (LLEIDA). Datos registrales. T 1146 , F 69, S 8, H L 22750, I/A 5 (25.03.10).
Desembolso de dividendos pasivos — 27/10/2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 519.785,00 Euros. Datos registrales. T 1146 , F 68, S 8, H L 22750, I/A 4 (15.10.09).
Desembolso de dividendos pasivos — 20/08/2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 220.000,00 Euros. Datos registrales. T 1146 , F 67, S 8, H L 22750, I/A 3 (10.08.09).