Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 6 tarjetas
13/08/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-337484

Nombramientos — 13/08/2015

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GADEA ANTONIO. Datos registrales. T 32384 , F 8, S 8, H M 260998, I/A 23 ( 5.08.15).

26/06/2015 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-264135

Ampliación de capital — 26/06/2015

Ampliación de capital. Capital: 98.590,00 Euros. Resultante Suscrito: 101.595,06 Euros. Datos registrales. T 32384 , F 8, S 8, H M 260998, I/A 22 (18.06.15).

17/03/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-114221

Revocaciones — 17/03/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: IMAZ RUBALCABA JAVIER. Apoderado: ZAYAS SATRUSTEGUI LUIS;LORENZO TORETS ANA. Datos registrales. T 32384 , F 6, S 8, H M 260998, I/A 18 (10.03.15).

17/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-114222

Nombramientos — 17/03/2015

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ RAFAEL. Datos registrales. T 32384 , F 6, S 8, H M 260998, I/A 19 (10.03.15).

31/01/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-46248

Nombramientos — 31/01/2014

Nombramientos. Apoderado: ZAYAS SATRUSTEGUI LUIS. Apo.Manc.: IMAZ RUBALCABA JAVIER;DE ORIOL E ICAZA MONICA. Datos registrales. T 15518 , F 195, S 8, H M 260998, I/A 10 (23.01.14).

30/12/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-556566

Nombramientos — 30/12/2013

Nombramientos. Apo.Man.Soli: IMAZ RUBALCABA JAVIER. Apo.Manc.: DE ORIOL E ICAZA MONICA. Datos registrales. T 15518 , F 193, S 8, H M 260998, I/A 9 (20.12.13).