Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 7 tarjetas
12/06/2019 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-253697

Modificaciones estatutarias — 12/06/2019

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 1. Denominación social.-. Cambio de denominación social. PANTHER JUICE & SANDWICH MARKET COMPANY SL. Datos registrales. T 34578 , F 122, S 8, H M 553466, I/A 22 (...

21/01/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-23795

Revocaciones — 21/01/2019

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VARANDA IGNACIO. Datos registrales. T 34578 , F 122, S 8, H M 553466, I/A 21 (14.01.19).

19/06/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-252614

Nombramientos — 19/06/2017

Nombramientos. Apoderado: SOTO GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 34578 , F 121, S 8, H M 553466, I/A 20 ( 9.06.17).

06/05/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-196112

Nombramientos — 06/05/2016

Nombramientos. Apoderado: SOTO GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 30757 , F 207, S 8, H M 553466, I/A 18 (28.04.16).

04/03/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-103863

Ceses/dimisiones — 04/03/2016

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN GIL MARIA BELEN. Datos registrales. T 30757 , F 207, S 8, H M 553466, I/A 16 (25.02.16).

04/03/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-103864

Revocaciones — 04/03/2016

Revocaciones. Apoderado: LOPEZ VIZCANO JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 30757 , F 207, S 8, H M 553466, I/A 17 (25.02.16).

22/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-303181

Revocaciones — 22/07/2015

Revocaciones. Apoderado: ROY MORALES ANA MARIA;ROY MORALES ANA MARIA. Datos registrales. T 30757 , F 203, S 8, H M 553466, I/A 13 (14.07.15).