Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 20 tarjetas
24/04/2019 Sec. I Disolución Guadalajara
Guadalajara-179902

Disolución — 24/04/2019

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 566 , F 92, S 8, H GU 7609, I/A 33 (10.04.19).

11/08/2017 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-333391

Nombramientos — 11/08/2017

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LACASIA PURROY JESUS;CORRALES CORRALES ANTONIO. Datos registrales. T 566 , F 90, S 8, H GU 7609, I/A 32 (28.07.17).

08/08/2017 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-326627

Revocaciones — 08/08/2017

Revocaciones. Apoderado: LACASIA PURROY JESUS;BERROJALBIZ AÑIBARRO ANA MARIA. Datos registrales. T 566 , F 89, S 8, H GU 7609, I/A 31 (28.07.17).

18/11/2016 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-467058

Nombramientos — 18/11/2016

Nombramientos. Apoderado: CORRALES CORRALES ANTONIO. Datos registrales. T 566 , F 89, S 8, H GU 7609, I/A 30 ( 7.11.16).

23/09/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-386270

Ceses/dimisiones — 23/09/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: PARQUES INTERMODALES NUEVAS AREAS DE ACTIVIDAD GRA;NORCENTRO 2000 SL;METROVACESA S.A.;CAJA CASTILLA LA MANCHA INICIATIVAS INDUSTRIALES S;PARQUES INTERMODALES GRAN EUROPA S.A. Presidente: PAR...

13/02/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-64558

Ceses/dimisiones — 13/02/2015

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GUTIERREZ IGLESIAS JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Vicesecret.: DE LA MORA AREITIO CARLOS. Datos registrales. T 566 , F 87, S 8, H GU 7609, I/A 26 ( 4.02.15).

19/12/2014 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-518511

Revocaciones — 19/12/2014

Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ NEGRO RAMON. Datos registrales. T 566 , F 86, S 8, H GU 7609, I/A 25 (10.12.14).

17/11/2014 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-464341

Nombramientos — 17/11/2014

Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. Datos registrales. T 566 , F 86, S 8, H GU 7609, I/A 24 ( 4.11.14).

09/06/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-240479

Ceses/dimisiones — 09/06/2014

Ceses/Dimisiones. Secretario: BERROJALBIZ AÑIBARRO ANA MARIA. Presidente: NORCENTRO 2000 SL. Nombramientos. SecreNoConsj: CERON HERNANDEZ GONZALO. VsecrNoConsj: GUTIERREZ IGLESIAS JUAN FRANCISCO. Presidente: PARQUES INT...

09/06/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-240480

Ceses/dimisiones — 09/06/2014

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: NORCENTRO 2000 SL. Nombramientos. Cons.Del.Man: PARQUES INTERMODALES GRAN EUROPA S.A.;METROVACESA S.A.;NORCENTRO 2000 SL. Datos registrales. T 566 , F 85, S 8, H GU 7609, I/A 23 (30.05.14...

11/04/2014 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-162825

Nombramientos — 11/04/2014

Nombramientos. Auditor: OLIVEROS LAPUERTA SANTIAGO MANUEL. Datos registrales. T 1, L 1, F 125, S 8, H GU 7609, I/A 1 (31.03.14).

11/10/2013 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-436663

Revocaciones — 11/10/2013

Revocaciones. Apoderado: TELLERIA GARMENDIA EDUARDO;TELLERIA GARMENDIA EDUARDO. Datos registrales. T 566 , F 84, S 8, H GU 7609, I/A 20 ( 1.10.13).

12/07/2013 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-316957

Nombramientos — 12/07/2013

Nombramientos. Consejero: PARQUES INTERMODALES GRAN EUROPA S.A. Datos registrales. T 566 , F 83, S 8, H GU 7609, I/A 18 (25.06.13).

01/03/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-103806

Ceses/dimisiones — 01/03/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: PARQUES INDUSTRIALES GRAN EUROPA S.A. Datos registrales. T 566 , F 83, S 8, H GU 7609, I/A 17 (13.02.13).

27/11/2012 Sec. I Otros conceptos: Don Emilio Campmany Bermejo, resuelve designar como EXPERTOpara la realización del informe preceptuado en el artículos71 Guadalajara
Guadalajara-487812

Otros conceptos: don emilio campmany bermejo, resuelve designar como expertopara la realización del informe preceptuado en el artículos71 — 27/11/2012

Otros conceptos: Don Emilio Campmany Bermejo, resuelve designar como EXPERTOpara la realización del informe preceptuado en el artículos71.6 de la Ley Concursal acerca del acuerdo de refinanciación entre el deudor DESARR...

27/11/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-487813

Ceses/dimisiones — 27/11/2012

Ceses/Dimisiones. Apoderado: VARA HERRERO FERNANDO;VARA HERRERO FERNANDO. Datos registrales. T 549 , F 142, S 8, H GU 7609, I/A 13 (13.11.12).

27/11/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-487814

Ceses/dimisiones — 27/11/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ORIOL Y LOPEZ MONTENEGRO LUCAS MARIA. Datos registrales. T 549 , F 142, S 8, H GU 7609, I/A 14 (13.11.12).

23/10/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-430911

Ceses/dimisiones — 23/10/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: ROS MAORAD JOSE LUIS. Presidente: ROS MAORAD JOSE LUIS. Nombramientos. Presidente: NORCENTRO 2000 SL. Datos registrales. T 549 , F 142, S 8, H GU 7609, I/A 12 ( 9.10.12).

01/06/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-233489

Ceses/dimisiones — 01/06/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: BERGARECHE BUSQUET SANTIAGO. Datos registrales. T 549 , F 141, S 8, H GU 7609, I/A 11 (23.05.12).

16/05/2012 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-207165

Revocaciones — 16/05/2012

Revocaciones. Apoderado: SOTO FERNANDEZ JOSE MARIA;SOTO FERNANDEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 549 , F 141, S 8, H GU 7609, I/A 10 (24.04.12).