Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 24 tarjetas
13/05/2016 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-207002

Nombramientos — 13/05/2016

Nombramientos. Apo.Sol.: CORRAL MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 581 , F 120, S 8, H GU 6118, I/A 45 ( 5.05.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 91 Viernes 13 de mayo de 2016 Pág. 22287 cve: BORME...

29/03/2016 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-138559

Revocaciones — 29/03/2016

Revocaciones. Apoderado: BRU TABERNERO ALFREDO;NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Apo.Man.Soli: GRANELL BALLESTER JUAN RAMON;ALVARO LOPEZ JOSE LUIS;MENDEZ SANCHEZ JESUS. Datos registrales. T 581 , F 120, S 8, H GU 6118, I/A 44 (17...

11/03/2016 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-115575

Nombramientos — 11/03/2016

Nombramientos. Apoderado: ESTEBAN GARCIA JUAN JOSE. Datos registrales. T 581 , F 118, S 8, H GU 6118, I/A 42 ( 4.03.16).

11/03/2016 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-115576

Nombramientos — 11/03/2016

Nombramientos. Apoderado: AMBITE CIFUENTES JUAN VICENTE. Datos registrales. T 581 , F 119, S 8, H GU 6118, I/A 43 ( 4.03.16).

12/02/2016 Sec. I Reelecciones Guadalajara
Guadalajara-64398

Reelecciones — 12/02/2016

Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SAU. Datos registrales. T 581 , F 118, S 8, H GU 6118, I/A 41 ( 2.02.16).

16/11/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-460036

Ceses/dimisiones — 16/11/2015

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DEDALO PRINT S.L. Nombramientos. Adm. Unico: SAMPER CANTOS FRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 581 , F 117, S 8, H GU 6118, I/A 40 ( 5.11.15).

06/11/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-449026

Ceses/dimisiones — 06/11/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: DEDALO PRINT S.L.;SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA SOCIEDAD GESTORA DE;4 PROY M&C S.L. Presidente: DEDALO PRINT S.L. Secretario: SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA SOCIEDAD GESTORA DE. Con.Delegad...

30/05/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-228225

Ceses/dimisiones — 30/05/2014

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DEDALO PRINT S.L. Nombramientos. Consejero: DEDALO PRINT S.L.;SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA SOCIEDAD GESTORA DE;4 PROY M&C S.L. Presidente: DEDALO PRINT S.L. Secretario: SHERPA CAPITAL ENT...

30/05/2014 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-228226

Nombramientos — 30/05/2014

Nombramientos. Apoderado: NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Datos registrales. T 581 , F 112, S 8, H GU 6118, I/A 34 (19.05.14).

30/05/2014 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-228227

Revocaciones — 30/05/2014

Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOZA BOSQUE PEDRO. Otros conceptos: Se revocan los poderes conferidos a ALEJANDRO ULLA DIEZ Y SANTOS ALVAREZ FANTOVA, en sendas escrituras autorizadas por el Notario de Madrid, Don Antonio Hu...

30/05/2014 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-228228

Nombramientos — 30/05/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ASEIJAS MUÑOZ ANGEL. Datos registrales. T 581 , F 113, S 8, H GU 6118, I/A 36 (19.05.14).

30/05/2014 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-228229

Nombramientos — 30/05/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRANELL BALLESTER JUAN RAMON. Datos registrales. T 581 , F 114, S 8, H GU 6118, I/A 37 (19.05.14).

30/05/2014 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-228230

Nombramientos — 30/05/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVARO LOPEZ JOSE LUIS;MENDEZ SANCHEZ JESUS. Datos registrales. T 581 , F 115, S 8, H GU 6118, I/A 38 (19.05.14).

20/08/2013 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-368511

Nombramientos — 20/08/2013

Nombramientos. Apoderado: BRU TABERNERO ALFREDO. Datos registrales. T 543 , F 133, S 8, H GU 6118, I/A 32 (30.07.13).

22/02/2013 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-90324

Revocaciones — 22/02/2013

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ZARAGOZA GARCIA NOEMI;ULLA DIEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 543 , F 133, S 8, H GU 6118, I/A 31 (13.02.13).

15/02/2013 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-77093

Nombramientos — 15/02/2013

Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SAU. Datos registrales. T 543 , F 132, S 8, H GU 6118, I/A 30 ( 5.02.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 32 Viernes 15 de febrero de 2013 Pág. 8113 cve: BORME...

25/01/2013 Sec. I Ampliacion del objeto social Guadalajara
Guadalajara-38966

Ampliacion del objeto social — 25/01/2013

Ampliacion del objeto social. La preimpresión, impresión y encuadernación de todo tipo de revistas, periódicos - cualquier otro tipo de publicaciones mediante aquellos sistemas deimpresión que se juzgue más conveniente...

26/07/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Guadalajara
Guadalajara-314353

Ceses/dimisiones — 26/07/2012

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DEDALO GRUPO GRAFICO SL. Nombramientos. Adm. Unico: DEDALO PRINT S.L. Datos registrales. T 543 , F 131, S 8, H GU 6118, I/A 28 (11.07.12).

03/07/2012 Sec. I Sociedad unipersonal Guadalajara
Guadalajara-279781

Sociedad unipersonal — 03/07/2012

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: DEDALO PRINT S.L. Datos registrales. T 543 , F 131, S 8, H GU 6118, I/A 27 (19.06.12).

19/04/2012 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-173304

Revocaciones — 19/04/2012

Revocaciones. Apo.Man.Soli: LIZARRAGA BONELLI JUAN;LORENZO ELVIRA JOSE RAMON. Datos registrales. T 543 , F 131, S 8, H GU 6118, I/A 26 (23.03.12).

29/11/2011 Sec. I Revocaciones Guadalajara
Guadalajara-476857

Revocaciones — 29/11/2011

Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ DELGADO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 543 , F 130, S 8, H GU 6118, I/A 24 ( 3.11.11).

29/11/2011 Sec. I Nombramientos Guadalajara
Guadalajara-476858

Nombramientos — 29/11/2011

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ULLA DIEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 543 , F 130, S 8, H GU 6118, I/A 25 ( 3.11.11).

02/11/2011 Sec. I Reelecciones Guadalajara
Guadalajara-434657

Reelecciones — 02/11/2011

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 543 , F 129, S 8, H GU 6118, I/A 23 ( 5.10.11).

30/03/2011 Sec. I Cambio de domicilio social Guadalajara
Guadalajara-142089

Cambio de domicilio social — 30/03/2011

Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO DE MEDINA Y MENDOZA - POLIGONO INDUS (CABANILLAS DEL CAMPO). Datos registrales. T 525 , F 76, S 8, H GU 6118, I/A 22N (12.02.11).