Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 6 tarjetas
15/01/2015 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-13833

Cambio de denominación social — 15/01/2015

Cambio de denominación social. VEOLIA CONTRACTING ESPAÑA SL. Datos registrales. T 20591 , F 222, S 8, H M 364523, I/A 38 ( 7.01.15).

12/07/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-317422

Nombramientos — 12/07/2013

Nombramientos. Apoderado: FONDEVILLA BARBER MIREIA CONCEPCION. Datos registrales. T 20591 , F 216, S 8, H M 364523, I/A 33 ( 4.07.13).

26/12/2012 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-537686

Reelecciones — 26/12/2012

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20591 , F 215, S 8, H M 364523, I/A 30 (18.12.12).

31/07/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-321456

Nombramientos — 31/07/2012

Nombramientos. Apoderado: MORROS MOYSSET JAVIER;CAMARERO CAMARERO JOSE LUIS;NAVALPOTRO GOMEZ EVA MARIA;MARCO ASENSIO LAURA;FONDEVILLA BARBER MIREIA CONCEPCION;CHAMPION SAMUEL;MARIA MICHEL HENRI;GONZALEZ LOUREIRO JUAN JO...

02/06/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-236073

Ceses/dimisiones — 02/06/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ DE LA CUEVA CONSTANTINO. Con.Delegado: ALVAREZ DE LA CUEVA CONSTANTINO. Consejero: ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN. Presidente: ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN. Consejero: ALVAREZ DIAZ DE CERIO...

02/06/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-236074

Nombramientos — 02/06/2011

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARIA MICHEL HENRI. Datos registrales. T 20591 , F 212, S 8, H M 364523, I/A 22 (23.05.11).