Actos destacados
Sociedad unipersonal — 27/08/2012
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: NCG DIVISION GRUPO INMOBILIARIO SL. Datos registrales. T 3413 , F 165, S 8, H C 35179, I/A 38 (16.08.12).
Ceses/dimisiones — 27/08/2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GALERAS - ENTRERIOS SL;GPS DEL NOROESTE 3000 SL. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 3413 , F 166, S 8, H C 35179, I/A 39 (16.08.12).
Ampliación de capital — 26/07/2012
Ampliación de capital. Capital: 31.149.450,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.769.040,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social. Datos registrales. T 3413 , F 165, S...
Nombramientos — 04/06/2012
Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO HERNANDEZ BELEN;ROMERO QUIROGA JOSE LUIS;MARTINEZ MOAR ANGEL MANUEL;ZAMORANO GOMEZ FRANCISCO JOSE;FEIJOO CEBRIAN FRANCISCO ISAAC;SIEYRO BOXER FRANCISCO JAVIER;CARREIRA MIGUEZ ALBERTO. Da...
Otros conceptos: se cambia el representante, persona física, de la entidad "geps del noroeste 3000, s — 26/04/2012
Otros conceptos: Se cambia el representante, persona física, de la entidad "GEPS DEL NOROESTE 3000, S. L.", pasando a ostentar dicha condición Don Alberto Carreira Miguez, y cesando como tal, Don Andrés Moreno Fernández...
Revocaciones — 16/03/2012
Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3413 , F 163, S 8, H C 35179, I/A 33 ( 7.03.12).
Ceses/dimisiones — 27/10/2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BECEGA EXCHANGE SL;CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL. Nombramientos. Adm. Mancom.: GALERAS - ENTRERIOS SL;GPS DEL NOROESTE 3000 SL. Datos registrales. T 3413 , F 163, S 8...
Nombramientos — 27/10/2011
Nombramientos. Apoderado: ZAMORANO GOMEZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3413 , F 163, S 8, H C 35179, I/A 32 (17.10.11).
Nombramientos — 07/06/2011
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ARIAS OLGA. Datos registrales. T 3413 , F 162, S 8, H C 35179, I/A 29 (30.05.11).
Nombramientos — 12/05/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO QUIROGA JOSE LUIS;GUITART DE LA TORRE FRANCO;MERCE ARGELICH MAGI;SANCHEZ SUAREZ SERGIO;REYES OJEDA MARIA BEATRIZ;GOMEZ CASTANERA PEDRO PABLO. Datos registrales. T 3413 , F 161, S 8, H C 3...
Nombramientos — 06/05/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN BERMUDEZ MIGUEL;DIAZ TOUZA JULIO;VENTOSO RAÑON DAVID. Datos registrales. T 3304 , F 195, S 8, H C 35179, I/A 24 (26.04.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 86 Viernes 6 de mayo...
Nombramientos — 06/05/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: VILA GONZALEZ JUAN JOSE;GARCIA FORTES ROBERTO ENRIQUE;GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDO;BUSTILLO FREIJIDO PABLO;GOMEZ MARTIN TERESA;FIGUEIRAS GANDARA JAVIER;MONTEAGUDO MORILLO DAVID;GARCIA LUJAN ANGEL V...
Nombramientos — 06/05/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ-RANDULFE ALVAREZ SANTIAGO LUIS;GARCIA FORTES PABLO;LOPEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 3413 , F 160, S 8, H C 35179, I/A 26 (26.04.11).
Nombramientos — 06/05/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVITE LORENZO PABLO MARIA;GARCIA REINO ANA DELFINA;SANCHEZ COUCE ROBERTO;GARCIA GARCIA JORGE;INFANTE NOGUEIRA MARIA;FARIÑA PARDO DE VERA JAVIER;RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA;GUTIERREZ BECKER...
Nombramientos — 04/05/2011
Nombramientos. Apo.Manc.: MORENO FERNANDEZ ANDRES;FEIJOO CEBRIAN FRANCISCO ISAAC. Datos registrales. T 3304 , F 194, S 8, H C 35179, I/A 22 (25.04.11).
Nombramientos — 04/05/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: FONTAN MONTES FERNANDO;MORENO FERNANDEZ ANDRES;DE LA COLINA BEJAR FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ ALVAREZ ELADIO. Datos registrales. T 3304 , F 195, S 8, H C 35179, I/A 23 (25.04.11).
Nombramientos — 13/04/2011
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3304 , F 194, S 8, H C 35179, I/A 21 ( 5.04.11).
Otros conceptos: don luis ignacio arrechea de miguel cesa como representantedel administrador mancomunado "corporacion empresarial y financiera de galicia sl" y se nombra en su lugar a don gregorio gorriaran laza — 18/02/2011
Otros conceptos: DON LUIS IGNACIO ARRECHEA DE MIGUEL CESA COMO REPRESENTANTEDEL ADMINISTRADOR MANCOMUNADO "CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL" Y SE NOMBRA EN SU LUGAR A DON GREGORIO GORRIARAN LAZA. Datos...
Revocaciones — 21/12/2010
Revocaciones. Apoderado: CELA DEL RIO ALVARO. Apo.Sol.: MENDEZ LOPEZ JOSE LUIS;MENDEZ PASCUAL JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: ALVAREZ ACEVEDO ALFONSO. Datos registrales. T 3304 , F 193, S 8, H C 35179, I/A 18 (13.12.10).
Ceses/dimisiones — 30/07/2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ARRECHEA DE MIGUEL LUIS IGNACIO;MORENO FERNANDEZ ANDRES. Nombramientos. Adm. Mancom.: BECEGA EXCHANGE SL;CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL. Datos registrales. T 3304 , F...
Fusión por absorción — 14/01/2009
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: CXG PATRIMONIO INMOBILIARIO CORPORACION CAIXAGALIC. CXG INMOBILIARIA CORPORACION CAIXAGALICIA SA. ALTABRAVA DEL MAR SL. HAYEDO DE MONTESALTOS SL. ALBAZUL DEL CASTILLO SL. VIL...