Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 17 tarjetas
18/11/2019 Sec. I Revocaciones Granada
Granada-475162

Revocaciones — 18/11/2019

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ MAROTO DANIEL;MARTINEZ CASTILLA CARLOS;MARTIN MARTOS JUAN ALFONSO. Apo.Sol.: BERRIO CASARES MANUEL. Apo.Man.Soli: CONTRERAS MARQUEZ PATROCINIO SACRAMENTO;HERNANDEZ JIMENEZ-CASQUET ENRIQ...

27/09/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Granada
Granada-404478

Ceses/dimisiones — 27/09/2019

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FRANCO CASANOVA ANA MARIA. Consejero: ROBLES LIZANCOS ANTONIO;RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;MUÑOZ DOMINGUEZ JOSE;BARRIOS DELGADO MANUEL;VIDONDO ILINCHETA JOSE JAV...

27/09/2019 Sec. I Revocaciones Granada
Granada-404479

Revocaciones — 27/09/2019

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ CASTILLA CARLOS;CORTES RODRIGUEZ JOSE RAFAEL. Apo.Manc.: ZAMORA MALAGON ANTONIO. Apo.Sol.: MORAL GARCIA-TRIVIÑO ALEJANDRO. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ JIMENEZ-CASQUET ENRIQUE. Apo.Sol.:...

25/04/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Granada
Granada-181961

Ceses/dimisiones — 25/04/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBLES GARCIA VICENTE;OSUNA HERVAS LUIS MARIA. Presidente: OSUNA HERVAS LUIS MARIA. Con.Delegado: OSUNA HERVAS LUIS MARIA. SecreNoConsj: TORRES GARCIA FRANCISCO DE PAULA. Nombramientos. Cons...

25/04/2019 Sec. I Revocaciones Granada
Granada-181962

Revocaciones — 25/04/2019

Revocaciones. Apo.Manc.: AGUILERA JIMENEZ MARIA. Apo.Man.Soli: CORTES RODRIGUEZ JOSE RAFAEL;ZAMORA MALAGON ANTONIO. Apo.Sol.: MARTINEZ CASTILLA CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ CASTILLA CARLOS;CORTES RODRIG...

18/01/2018 Sec. I Ampliación de capital Granada
Granada-26608

Ampliación de capital — 18/01/2018

Ampliación de capital. Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Desembolsado: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.550.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.550.000,00 Euros. Datos registrales. T 1512 , F 17, S 8, H GR 43...

04/04/2017 Sec. I Nombramientos Granada
Granada-150121

Nombramientos — 04/04/2017

Nombramientos. Consejero: CONTRERAS MARQUEZ PATROCINIO SACRAMENTO;NAVARRO GARCIA RUBEN AGUSTIN;CABRERA SABIO RAMON. Datos registrales. T 1512 , F 16, S 8, H GR 43945, I/A 11 (28.03.17).

01/03/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Granada
Granada-98468

Ceses/dimisiones — 01/03/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: URBANO PEREZ JOSE MARIA;ROS MUROS MARCIAL. Datos registrales. T 1512 , F 16, S 8, H GR 43945, I/A 10 (22.02.17).

17/08/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Granada
Granada-339263

Ceses/dimisiones — 17/08/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1512 , F 16, S 8, H GR 43945, I/A 9 ( 9.08.16).

12/05/2016 Sec. I Modificaciones estatutarias Granada
Granada-204999

Modificaciones estatutarias — 12/05/2016

Modificaciones estatutarias. Art. 12. Modificado en el sentido de que se incluye la posibilidad de poder celebrar la Junta General fuera del término municipal donde radica el domicilio social. Datos registrales. T 1512...

07/09/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Granada
Granada-364769

Ceses/dimisiones — 07/09/2015

Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ CASTILLA CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: TORRES GARCIA FRANCISCO DE PAULA. Datos registrales. T 1512 , F 15, S 8, H GR 43945, I/A 5 (31.08.15).

07/09/2015 Sec. I Modificaciones estatutarias Granada
Granada-364770

Modificaciones estatutarias — 07/09/2015

Modificaciones estatutarias. Art. 25. Se modifica el número máximo de Consejeros que integran el Consejo de Admón. . Datos registrales. T 1512 , F 15, S 8, H GR 43945, I/A 6 (31.08.15).

07/09/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Granada
Granada-364771

Ceses/dimisiones — 07/09/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUILERA JIMENEZ MARIA;MARTINEZ CASTILLA CARLOS. Nombramientos. Consejero: ROBLES LIZANCOS ANTONIO;LOPEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;MUÑOZ...

27/10/2014 Sec. I Nombramientos Granada
Granada-431355

Nombramientos — 27/10/2014

Nombramientos. Consejero: ROS MUROS MARCIAL. Otros conceptos: Fijar y elevar el números de miembros del Consejo de Administración que ahora estará compuesto por cinco consejeros. Datos registrales. T 1512 , F 15, S 8, H...

11/04/2014 Sec. I Nombramientos Granada
Granada-162755

Nombramientos — 11/04/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORTES RODRIGUEZ JOSE RAFAEL. Apo.Manc.: AGUILERA JIMENEZ MARIA. Apo.Man.Soli: ZAMORA MALAGON ANTONIO. Apo.Sol.: MARTINEZ CASTILLA CARLOS. Datos registrales. T 1512 , F 9, S 8, H GR 43945, I...

15/01/2014 Sec. I Constitución Granada
Granada-14279

Constitución — 15/01/2014

Constitución. Comienzo de operaciones: 1.01.14. Objeto social: a) La adquisición, para el suministro, distribución y venta a sus accionistas, socios, asociados y/o dientes, de toda clase de productos de alimentación, dr...

15/01/2014 Sec. I Nombramientos Granada
Granada-14280

Nombramientos — 15/01/2014

Nombramientos. Con.Delegado: OSUNA HERVAS LUIS MARIA. Datos registrales. T 1512 , F 13, S 8, H GR 43945, I/A 2 ( 3.01.14).