Actos destacados
Revocaciones — 12/12/2019
Revocaciones. Apo.Manc.: VAZQUEZ VILLA AURELIO. Apoderado: VAZQUEZ VILLA AURELIO. Apo.Manc.: MOSCARDO COVO RODRIGO;BENNASAR MARROIG BARTOLOME;VERA DOLS ANTONIO;BIBILONI CALAFELL BERNARDINO;VILA CRUZ RAMON. Apoderado: VE...
Fusión por absorción — 31/10/2019
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: FONTCAROLINA SL. Datos registrales. T 2806 , F 214, S 8, H PM 7573, I/A 45 (25.10.19).
Ceses/dimisiones — 02/09/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ VILLA AURELIO MANUEL. Con.Delegado: VAZQUEZ VILLA AURELIO MANUEL. Nombramientos. Consejero: MOTA OTERO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 2806 , F 214, S 8, H PM 7573, I/A 44 (23.08.1...
Nombramientos — 14/05/2019
Nombramientos. Apoderado: COSTOYA BARREIRO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2806 , F 214, S 8, H PM 7573, I/A 43 ( 6.05.19).
Nombramientos — 08/04/2019
Nombramientos. Apo.Manc.: LLOMPART SOLER FERRAN;LLOMPART BERNARDINO MARGARITA. Datos registrales. T 2382 , F 108, S 8, H PM 7573, I/A 42 ( 1.04.19).
Reducción de capital — 01/02/2019
Reducción de capital. Importe reducción: 192.770,75 Euros. Resultante Suscrito: 798.879,25 Euros. Datos registrales. T 2382 , F 107, S 8, H PM 7573, I/A 41 (25.01.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 22 Vier...
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 12/11/2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ZAFORTEZA Y DE OLIVES TOMAS;ZAFORTEZA DUQUE DE ESTRADA MARIA;VAZQUEZ VILLA AURELIO;ROSSELLO CERDA RAFAEL;LLOMPART SOLER ALBERTO. Presidente: ZAFORTEZA Y DE OLIVES TOM...
Nombramientos — 09/05/2018
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2382 , F 107, S 8, H PM 7573, I/A 39 (30.04.18).
Nombramientos — 28/09/2017
Nombramientos. Apoderado: ROSSELLO CERDA RAFAEL. Datos registrales. T 2382 , F 106, S 8, H PM 7573, I/A 38 (19.09.17).
Revocaciones — 18/11/2016
Revocaciones. Apo.Manc.: BIBILONI CALAFELL BERNARDINO;VAZQUEZ VILLA AURELIO;VERA DOLS ANTONIO;GARCIA CHELIZ MANUEL;BENNASSAR MARROIG BARTOLOME. Nombramientos. Apo.Manc.: VAZQUEZ VILLA AURELIO;MOSCARDO COVO RODRIGO;BENNA...
Ceses/dimisiones — 24/10/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ZAFORTEZA DUQUE ESTRADA MARIA AUXILIADORA;ZAFORTEZA Y DE OLIVES TOMAS;FLUXA ROSSELLO MIGUEL. Presidente: FLUXA ROSSELLO MIGUEL. Con.Delegado: FLUXA ROSSELLO MIGUEL. SecreNoConsj: LLOMPART SO...
Cambio de domicilio social — 24/10/2013
Cambio de domicilio social. C/ GENERAL RIERA 154 (PALMA DE MALLORCA). Datos registrales. T 2382 , F 106, S 8, H PM 7573, I/A 36 (18.10.13).
Revocaciones — 13/04/2012
Revocaciones. Apoderado: CORTES MIRO JAIME;CORTES MIRO JAIME;INSERTE ANGEL GINES SALVADOR;VALLES BOTA JOSE MARIA;AMENGUAL AVELLA JUAN MIGUEL;GARCIA CHELIZ MANUEL;RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO;LLOMPART CORTES SEBASTIAN;GAR...
Ceses/dimisiones — 04/05/2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: BAÑUELOS BERASATEGUI MARIA ESTIBALIZ. Nombramientos. SecreNoConsj: LLOMPART SOLER ALBERTO. Datos registrales. T 2382 , F 104, S 8, H PM 7573, I/A 30 (23.04.10).
Ceses/dimisiones — 16/06/2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTOS MACKOW FERNANDO MIGUEL. Nombramientos. Secretario: BAÑUELOS BERASATEGUI MARIA ESTIBALIZ. Datos registrales. T 2382 , F 104, S 8, H PM 7573, I/A 29 ( 4.06.09).
Nombramientos — 29/04/2009
Nombramientos. Apoderado: ROSSELLO CERDA RAFAEL. Datos registrales. T 2321 , F 154, S 8, H PM 7573, I/A 28 (14.04.09).