Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 13 tarjetas
17/01/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-19570

Ceses/dimisiones — 17/01/2019

Ceses/Dimisiones. Secretario: SEOANE PERNAS JOSE. Presidente: SANCHO COLAS MANUEL CARMELO. Cons.Del.Man: SANCHO COLAS MANUEL CARMELO. Consejero: SANCHO COLAS MANUEL CARMELO;ESCRICHE ARANDIA JAVIER;GIMENO RABANAQUE FRANC...

05/05/2016 Sec. I Reelecciones Teruel
Teruel-194525

Reelecciones — 05/05/2016

Reelecciones. Auditor: CONAUDIRE SLP. Datos registrales. T 224, L 224, F 171, S 8, H TE 4325, I/A 13 (26.04.16).

27/04/2016 Sec. I Nombramientos Teruel
Teruel-183805

Nombramientos — 27/04/2016

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHO COLAS MANUEL CARMELO;RANDO SALAS FELIX. Datos registrales. T 224, L 224, F 171, S 8, H TE 4325, I/A 12 (14.04.16).

01/09/2015 Sec. I Revocaciones Teruel
Teruel-358020

Revocaciones — 01/09/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: LIZAMA CORTES JOSE MANUEL;SANCHO COLAS MANUEL CARMELO;SANCHEZ LAZARO MARTIN. Datos registrales. T 224, L 224, F 154, S 8, H TE 4325, I/A 11 (10.08.15).

20/08/2015 Sec. I Modificaciones estatutarias Teruel
Teruel-346809

Modificaciones estatutarias — 20/08/2015

Modificaciones estatutarias. "Artículo TRECE.- Convocatoria. 13.1. La Junta General será convocada por el órgano de administración o, en su caso, por los liquidadores o, en los casos a que se refieren los artículos 169,...

14/05/2015 Sec. I Reelecciones Teruel
Teruel-197535

Reelecciones — 14/05/2015

Reelecciones. Auditor: CONAUDIRE SLP. Datos registrales. T 224, L 224, F 154, S 8, H TE 4325, I/A 9 ( 4.05.15).

25/02/2015 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos Teruel
Teruel-83857

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 25/02/2015

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: RUBIO GARCES JOSE JAVIER. Reelecciones. Consejero: SANCHEZ LAZARO MARTIN;SANCHO COLAS MANUEL CARMELO;LIZAMA CORTES TEODORO FLORENCIO;LIZAMA CORTES JOAQUIN;LIZAMA CORT...

25/02/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-83858

Ceses/dimisiones — 25/02/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ LAZARO MARTIN;SANCHO COLAS MANUEL CARMELO;LIZAMA CORTES TEODORO FLORENCIO;LIZAMA CORTES JOAQUIN;LIZAMA CORTES JOSE MANUEL;GARCIA FERRER ILDEFONSO RAMON;ESCRICHE ARANDIA JAVIER;HERNAN...

25/02/2015 Sec. I Desembolso de dividendos pasivos Teruel
Teruel-83859

Desembolso de dividendos pasivos — 25/02/2015

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 183.750,00 Euros. Datos registrales. T 224, L 224, F 142, S 8, H TE 4325, I/A 6 (16.02.15).

25/02/2015 Sec. I Nombramientos Teruel
Teruel-83860

Nombramientos — 25/02/2015

Nombramientos. Auditor: CONAUDIRE SLP. Datos registrales. T 224, L 224, F 142, S 8, H TE 4325, I/A 7 (16.02.15).

25/02/2015 Sec. I Reducción de capital Teruel
Teruel-83861

Reducción de capital — 25/02/2015

Reducción de capital. Importe reducción: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.000,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 8.000.000,00 Euros. Desembolsado: 8.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.500.000,0...

20/11/2009 Sec. I Nombramientos Teruel
Teruel-486996

Nombramientos — 20/11/2009

Nombramientos. Auditor: INDEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 224, L 224, F 141, S 8, H TE 4325, I/A 3 (10.11.09).

09/02/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-69545

Ceses/dimisiones — 09/02/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: SALA ESTEBAN MAGI. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Como consecuencia del cambio enla fecha del cierre del ejercicio se modifica la redacción del art. 5º de los Estatu...