Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 15 tarjetas
08/01/2019 Sec. I Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE 6 MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 RRM Zaragoza
Zaragoza-6467

Otros conceptos: cerrada la hoja por plazo provisional de 6 meses, conforme al articulo 231 rrm — 08/01/2019

Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE 6 MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 RRM. Datos registrales. T 4250 , F 52, S 8, H Z 31868, I/A 16 F (31.12.18). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERC...

28/12/2017 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-511165

Nombramientos — 28/12/2017

Nombramientos. Apo.Sol.: CREIXELL DE VILALLONGA VICTOR;CREIXELL DE VILALLONGA OSCAR. Datos registrales. T 4250 , F 52, S 8, H Z 31868, I/A 16 (20.12.17).

26/04/2017 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-180396

Revocaciones — 26/04/2017

Revocaciones. Apoderado: CAPELLA GASOL ALBERT. Datos registrales. T 4250 , F 52, S 8, H Z 31868, I/A 15 (19.04.17).

25/04/2017 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-178095

Nombramientos — 25/04/2017

Nombramientos. Apoderado: VALCARCEL SITJA ALBERT. Datos registrales. T 2835 , F 50, S 8, H Z 31868, I/A 14 (18.04.17).

28/11/2014 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-487763

Revocaciones — 28/11/2014

Revocaciones. Apoderado: DIEZ-ANTOÑANZAS GONZALEZ MARIA-LOURDES. Datos registrales. T 2835 , F 49, S 8, H Z 31868, I/A 10 (21.11.14).

28/11/2014 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-487764

Revocaciones — 28/11/2014

Revocaciones. Apoderado: DIEZ-ANTOÑANZAS GONZALEZ MARIA-LOURDES. Datos registrales. T 2835 , F 50, S 8, H Z 31868, I/A 11 (21.11.14).

28/11/2014 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-487765

Revocaciones — 28/11/2014

Revocaciones. Apoderado: DIEZ ANTOÑANZAS GONZALEZ MARIA INES. Datos registrales. T 2835 , F 50, S 8, H Z 31868, I/A 12 (21.11.14).

28/11/2014 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-487766

Nombramientos — 28/11/2014

Nombramientos. Apoderado: CAPELLA GASOL ALBERT. Datos registrales. T 2835 , F 50, S 8, H Z 31868, I/A 13 (21.11.14).

28/05/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-225951

Nombramientos — 28/05/2012

Nombramientos. Apoderado: DIEZ-ANTOÑANZAS GONZALEZ MARIA-LOURDES;PINEDA CALVO MIRIAM. Datos registrales. T 2835 , F 49, S 8, H Z 31868, I/A 9 (16.05.12).

10/02/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-70082

Nombramientos — 10/02/2012

Nombramientos. Apoderado: DIEZ-ANTOÑANZAS GONZALEZ MARIA-LOURDES. Datos registrales. T 2835 , F 49, S 8, H Z 31868, I/A 8 (31.01.12).

27/01/2012 Sec. I Ampliación de capital Zaragoza
Zaragoza-43715

Ampliación de capital — 27/01/2012

Ampliación de capital. Capital: 45.150,00 Euros. Resultante Suscrito: 48.160,00 Euros. Datos registrales. T 2835 , F 49, S 8, H Z 31868, I/A 7 (17.01.12).

13/12/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-494944

Nombramientos — 13/12/2011

Nombramientos. Apoderado: CREIXELL SUREDA JORDI. Datos registrales. T 2835 , F 48, S 8, H Z 31868, I/A 6 (30.11.11).

02/06/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-237141

Nombramientos — 02/06/2011

Nombramientos. Apoderado: DIEZ ANTOÑANZAS GONZALEZ MARIA INES. Datos registrales. T 2835 , F 47, S 8, H Z 31868, I/A 4 (23.05.11).

02/06/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-237142

Nombramientos — 02/06/2011

Nombramientos. Apoderado: BONET HERAS JORDI. Datos registrales. T 2835 , F 48, S 8, H Z 31868, I/A 5 (23.05.11).

12/05/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-204809

Ceses/dimisiones — 12/05/2011

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DIEZ-ANTOÑANZAS GONZALEZ MARIA-LOURDES;DIEZ ANTOÑANZAS GONZALEZ MARIA INES. Nombramientos. Adm. Unico: SECOND CODE SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Adm...