Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2013 7 tarjetas
09/12/2013 Sec. I Transformación de sociedad Almería
Almería-522831

Transformación de sociedad — 09/12/2013

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS ANDALUZAS SL. Reelecciones. Consejero: GUTIERREZ DELGADO JAVIER;GUTIERREZ DELGADO ALBERTO;DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS;...

26/04/2013 Sec. I Segregación Almería
Almería-195944

Segregación — 26/04/2013

Segregación. Beneficiarios de la segregación: GRUPOCOPSA SL. Datos registrales. T 1244 , F 32, S 8, H AL 1948, I/A 27 (17.04.13).

11/03/2013 Sec. I Revocaciones Almería
Almería-117760

Revocaciones — 11/03/2013

Revocaciones. Auditor: JUAN RONDA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 1244 , F 31, S 8, H AL 1948, I/A 26 (26.02.13).

20/12/2012 Sec. I Nombramientos Almería
Almería-528385

Nombramientos — 20/12/2012

Nombramientos. Auditor: JUAN RONDA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 1244 , F 31, S 8, H AL 1948, I/A 25 (13.12.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 243 Jueves 20 de diciembre de 2012 Pág. 57126 cve: BORM...

10/05/2010 Sec. I Nombramientos Almería
Almería-185890

Nombramientos — 10/05/2010

Nombramientos. Auditor: JUAN RONDA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 1244 , F 30, S 8, H AL 1948, I/A 23 (27.04.10).

10/05/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Almería
Almería-185891

Ceses/dimisiones — 10/05/2010

Ceses/Dimisiones. Presidente: GUTIERREZ DELGADO JAVIER. Consejero: GUTIERREZ DELGADO JAVIER. Secretario: GUTIERREZ DELGADO ALBERTO. Consejero: GUTIERREZ DELGADO ALBERTO;DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS. Con.Delega...

23/12/2009 Sec. I Revocaciones Almería
Almería-532389

Revocaciones — 23/12/2009

Revocaciones. Apoderado: ESCAMEZ ABAD FRANCISCO. Datos registrales. T 1244 , F 30, S 8, H AL 1948, I/A 22 (10.12.09).