Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2011 14 tarjetas
24/01/2011 Sec. I Disolución Castellón
Castellón-26431

Disolución — 24/01/2011

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1256, L 819, F 169, S 8, H CS 6702, I/A 48 (11.01.11).

21/01/2011 Sec. I Escisión parcial Castellón
Castellón-24268

Escisión parcial — 21/01/2011

Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: PROMOCIONES PAI GOLF SL. Datos registrales. T 1256, L 819, F 168, S 8, H CS 6702, I/A 47 (11.01.11).

07/06/2010 Sec. I Reelecciones Castellón
Castellón-224291

Reelecciones — 07/06/2010

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1256, L 819, F 168, S 8, H CS 6702, I/A 46 (26.05.10).

12/05/2010 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-190187

Revocaciones — 12/05/2010

Revocaciones. Apoderado: ENRIQUEZ MUÑOZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 1256, L 819, F 168, S 8, H CS 6702, I/A 44 (29.04.10).

12/05/2010 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-190188

Revocaciones — 12/05/2010

Revocaciones. Apoderado: GALLEGO DIAZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 1256, L 819, F 168, S 8, H CS 6702, I/A 45 (29.04.10). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 89 Miércoles 12 de mayo de 2010 Pág. 23649 cve...

07/04/2010 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-139625

Nombramientos — 07/04/2010

Nombramientos. Apoderado: MORENO JORGE RAUL. Datos registrales. T 1256, L 819, F 168, S 8, H CS 6702, I/A 43 (25.03.10).

25/01/2010 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-27703

Revocaciones — 25/01/2010

Revocaciones. Apo.Manc.: ARMIJO MELGUIZO ALBERTO. Datos registrales. T 1256, L 819, F 168, S 8, H CS 6702, I/A 42 (14.01.10).

18/01/2010 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-15913

Nombramientos — 18/01/2010

Nombramientos. Apoderado: GIMENO PALOMO BEATRIZ. Datos registrales. T 1256, L 819, F 166, S 8, H CS 6702, I/A 41 ( 5.01.10).

20/04/2009 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-186281

Nombramientos — 20/04/2009

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RIVAS GARCIA FEDERICO MIGUEL. Apo.Manc.: ARMIJO MELGUIZO ALBERTO;DE MONTIS CLARAMONTE GLORIA. Apo.Man.Soli: IBAÑEZ TENA JUAN CARLOS. Apo.Manc.: DIEZ ROVIRA ANTONIO. Datos registrales. T 1256...

08/04/2009 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-172662

Nombramientos — 08/04/2009

Nombramientos. Con.Delegado: GESTION CARTERA CASTELLON SL. Datos registrales. T 1256, L 819, F 166, S 8, H CS 6702, I/A 37 (30.03.09).

08/04/2009 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-172663

Nombramientos — 08/04/2009

Nombramientos. Apoderado: ENRIQUEZ MUÑOZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 1256, L 819, F 166, S 8, H CS 6702, I/A 38 (30.03.09).

08/04/2009 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-172664

Revocaciones — 08/04/2009

Revocaciones. Apo.Manc.: DIEZ ROVIRA ANTONIO. Apo.Man.Soli: RIVAS GARCIA FEDERICO MIGUEL;IBAÑEZ TENA JUAN CARLOS. Apo.Manc.: RIVAS GARCIA FEDERICO MIGUEL;IBAÑEZ TENA JUAN CARLOS;DIEZ ROVIRA ANTONIO;ARMIJO MELGUIZO ALBER...

30/03/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Castellón
Castellón-154554

Ceses/dimisiones — 30/03/2009

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GER GARCIA JESUS. Consejero: GER GARCIA JESUS. Presidente: GER GARCIA JESUS. Consejero: RIVAS GARCIA FEDERICO. Nombramientos. Consejero: FONDOCAS SOCIEDAD ANONIMA;GESTION CARTERA CASTELLO...

30/03/2009 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-154555

Nombramientos — 30/03/2009

Nombramientos. Presidente: GESTION CARTERA CASTELLON SL. Datos registrales. T 1256, L 819, F 166, S 8, H CS 6702, I/A 36 (18.03.09).