Actos destacados
Cambio de denominación social — 25/11/2013
Cambio de denominación social. CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 170, S 8, H MA 8098, I/A 104 (13.11.13).
Nombramientos — 21/08/2013
Nombramientos. Adm. Unico: SANDO INFRAESTRUCTURAS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.10. Administración y Representacion.-. Datos regist...
Nombramientos — 01/07/2013
Nombramientos. Apoderado: LARA SANTIAGO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 169, S 8, H MA 8098, I/A 102 (20.06.13).
Reelecciones — 28/12/2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 169, S 8, H MA 8098, I/A 101 (18.12.12).
Nombramientos — 04/07/2012
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ MOLINA JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 169, S 8, H MA 8098, I/A 99 (22.06.12).
Revocaciones — 04/07/2012
Revocaciones. Apoderado: MENDIGUCHIA GARCIA JORGE. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 169, S 8, H MA 8098, I/A 100 (22.06.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 126 Miércoles 4 de julio de 2012 Pág. 30821 cv...
Revocaciones — 19/06/2012
Revocaciones. Apoderado: VILLODRES PADILLA JOSE. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 169, S 8, H MA 8098, I/A 98 ( 5.06.12).
Nombramientos — 23/02/2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 169, S 8, H MA 8098, I/A 97 ( 9.02.12).
Nombramientos — 04/04/2011
Nombramientos. Apoderado: ESCAMEZ ABAD JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 167, S 8, H MA 8098, I/A 92 (23.03.11).
Revocaciones — 13/01/2011
Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ LUCINI JOSE ANTONIO. Apoderado: JIMENEZ LUCINI JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 167, S 8, H MA 8098, I/A 90 (27.12.10).
Ampliacion del objeto social — 23/12/2010
Ampliacion del objeto social. La colocación de todo tipo de pavimentos asfálticos.- Cualquier tipo de instalación complementaria a las propias del objeto social, y, específicamente las siguientes: La instalaciones eléct...
Nombramientos — 10/11/2010
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MANZANO LUIS. Datos registrales. T 1890, L 803, F 105, S 8, H MA 8098, I/A 88 (27.10.10).
Ceses/dimisiones — 20/09/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS;SANCHEZ MANZANO MARIA ESTHER;SANCHEZ MANZANO LUIS;SANCHEZ MANZANO JUAN ANGEL;SANCHEZ MANZANO ROSANA. Presidente: SANCHEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS. Secretario: SANCHEZ...
Revocaciones — 23/03/2010
Revocaciones. Apoderado: GRACIAN GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 1890, L 803, F 105, S 8, H MA 8098, I/A 86 ( 9.03.10).
Nombramientos — 15/03/2010
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1890, L 803, F 105, S 8, H MA 8098, I/A 85 (25.02.10).
Nombramientos — 08/01/2010
Nombramientos. Apo.Manc.: RUZ RAMOS JESUS;HIDALGO GAVIRA VICENTE;FERNANDEZ BARRON MANUEL;VICIOSO JIMENEZ PABLO;FLORES ALES JOSE MARIA;SANCHEZ CAÑETE ALEJANDRO;AZNAR ALMAZAN MARIO LUIS;GAMIZ PEREZ JORGE ALBERTO;GARCIA VA...
Nombramientos — 26/03/2009
Nombramientos. Apoderado: LARA SANTIAGO JOSE MANUEL. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1890, L 803, F 103, S 8, H MA 8098, I/A 78 (10.03.09).
Nombramientos — 26/03/2009
Nombramientos. Apoderado: GAMIZ PEREZ JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 1890, L 803, F 103, S 8, H MA 8098, I/A 80 (10.03.09).
Revocaciones — 26/03/2009
Revocaciones. Apoderado: LARA SANTIAGO JOSE MANUEL;GAMIZ PEREZ JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 1890, L 803, F 104, S 8, H MA 8098, I/A 81 (10.03.09).