Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 24 tarjetas
19/11/2019 Sec. I Reelecciones Jaén
Jaén-477492

Reelecciones — 19/11/2019

Reelecciones. Adm. Unico: MURIEL VAZQUEZ GESTION S.L. Datos registrales. T 532 , F 73, S 8, H J 1039, I/A 128 (13.11.19).

15/01/2019 Sec. I Ampliación de capital Jaén
Jaén-14625

Ampliación de capital — 15/01/2019

Ampliación de capital. Suscrito: 1.500.000,00 Euros. Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.660.786,31 Euros. Resultante Desembolsado: 2.660.786,31 Euros. Datos registrales. T 532 , F 73, S 8, H J 1039...

19/11/2018 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-460461

Nombramientos — 19/11/2018

Nombramientos. Apoderado: ANAYA GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 532 , F 72, S 8, H J 1039, I/A 125 (12.11.18).

19/11/2018 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-460462

Nombramientos — 19/11/2018

Nombramientos. Apoderado: URETA MESA LUIS. Datos registrales. T 532 , F 72, S 8, H J 1039, I/A 126 (12.11.18).

06/11/2018 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-442639

Revocaciones — 06/11/2018

Revocaciones. Apoderado: SANZ CEREZUELA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 532 , F 72, S 8, H J 1039, I/A 124 (29.10.18).

22/01/2018 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-30867

Nombramientos — 22/01/2018

Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 532 , F 72, S 8, H J 1039, I/A 123 (15.01.18).

16/11/2017 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-449968

Revocaciones — 16/11/2017

Revocaciones. Apo.Manc.: PEREZ TRUJILLOS ISABEL. Datos registrales. T 532 , F 71, S 8, H J 1039, I/A 121 ( 9.11.17).

16/11/2017 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-449969

Revocaciones — 16/11/2017

Revocaciones. Apoderado: PEREZ TRUJILLOS ISABEL. Datos registrales. T 532 , F 71, S 8, H J 1039, I/A 122 ( 9.11.17).

07/07/2017 Sec. I Ampliación de capital Jaén
Jaén-281224

Ampliación de capital — 07/07/2017

Ampliación de capital. Suscrito: 1.100.786,31 Euros. Desembolsado: 1.100.786,31 Euros. Resultante Suscrito: 1.160.786,31 Euros. Resultante Desembolsado: 1.160.786,31 Euros. Datos registrales. T 532 , F 72, S 8, H J 1039...

03/05/2017 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-184770

Nombramientos — 03/05/2017

Nombramientos. Apoderado: SANZ CEREZUELA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 532 , F 70, S 8, H J 1039, I/A 118 (25.04.17).

03/05/2017 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-184771

Revocaciones — 03/05/2017

Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Apo.Sol.: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Datos registrales. T 532 , F 71, S 8, H J 1039, I/A 119...

17/04/2017 Sec. I Reducción de capital Jaén
Jaén-165364

Reducción de capital — 17/04/2017

Reducción de capital. Importe reducción: 7.254.316,04 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 532 , F 69, S 8, H J 1039, I/A 117 ( 6.04.17).

28/02/2017 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-95612

Nombramientos — 28/02/2017

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Datos registrales. T 532 , F 67, S 8, H J 1039, I/A 116 (21.02.17).

04/03/2015 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-94626

Nombramientos — 04/03/2015

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 532 , F 67, S 8, H J 1039, I/A 115 (25.02.15).

02/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-89570

Ceses/dimisiones — 02/03/2015

Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: SERRA GOMEZ LUIS. Datos registrales. T 532 , F 66, S 8, H J 1039, I/A 111 (23.02.15).

02/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-89571

Ceses/dimisiones — 02/03/2015

Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: SERRANO CARRILLO FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 532 , F 66, S 8, H J 1039, I/A 112 (23.02.15).

02/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-89572

Ceses/dimisiones — 02/03/2015

Ceses/Dimisiones. Apoderado: NIETO MOYANO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 532 , F 67, S 8, H J 1039, I/A 113 (23.02.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 41 Lunes 2 de marzo de 2015 Pág. 9502 cve: BORME-A-...

02/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-89573

Ceses/dimisiones — 02/03/2015

Ceses/Dimisiones. Apoderado: HINOJOSA JIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 532 , F 67, S 8, H J 1039, I/A 114 (23.02.15).

16/02/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-67305

Ceses/dimisiones — 16/02/2015

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: MURIEL VAZQUEZ GESTION S.L. Datos registrales. T 532 , F 66, S 8, H J 1039, I/A 110 ( 9.02.15).

20/01/2015 Sec. I Revocaciones Jaén
Jaén-21640

Revocaciones — 20/01/2015

Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 532 , F 66, S 8, H J 1039, I/A 109 (13.01.15).

10/03/2014 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-108127

Nombramientos — 10/03/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Datos registrales. T 532 , F 64, S 8, H J 1039, I/A 108 ( 3.03.14).

20/01/2014 Sec. I Sociedad unipersonal Jaén
Jaén-23651

Sociedad unipersonal — 20/01/2014

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MURIEL VAZQUEZ GESTION S.L. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DERPROSA FILM SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Unico: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Datos registra...

20/01/2014 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-23652

Nombramientos — 20/01/2014

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Datos registrales. T 254 , F 87, S 8, H J 1039, I/A 102 (13.01.14).

20/01/2014 Sec. I Nombramientos Jaén
Jaén-23653

Nombramientos — 20/01/2014

Nombramientos. Apoderado: PEREZ TRUJILLOS ISABEL. Datos registrales. T 254 , F 87, S 8, H J 1039, I/A 103 (13.01.14).