Actos destacados
Modificaciones estatutarias — 20/03/2015
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-. Cambio de denominación social. SERVICENTRAL GRUPO CONCESUR, SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5532 , F 25, S 8, H SE 64315, I/A 24 (11.03....
Nombramientos — 15/01/2014
Nombramientos. Consejero: SERRANO FERNANDEZ RICARDO. Datos registrales. T 5532 , F 25, S 8, H SE 64315, I/A 23 ( 7.01.14).
Nombramientos — 01/10/2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARRANZA ALVAREZ JOSE CRISTOBAL;ALCALA GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 5532 , F 23, S 8, H SE 64315, I/A 22 (24.09.13).
Revocaciones — 01/10/2013
Revocaciones. Apo.Manc.: CARRANZA ALVAREZ JOSE CRISTOBAL;ALCALA GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 5532 , F 23, S 8, H SE 64315, I/A 21 (24.09.13).
Revocaciones — 12/09/2013
Revocaciones. Apoderado: CARRANZA ALVAREZ JOSE CRISTOBAL. Datos registrales. T 5532 , F 23, S 8, H SE 64315, I/A 20 ( 3.09.13).
Revocaciones — 22/05/2013
Revocaciones. Apo.Manc.: ALCALA GARCIA RAFAEL;PERAL RIOS ENRIQUE. Datos registrales. T 5532 , F 23, S 8, H SE 64315, I/A 19 (15.05.13).
Ceses/dimisiones — 12/12/2012
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: RODRIGUEZ PEREZ DE AYALA JOSE MANUEL. SecreNoConsj: BENITEZ RINCON DAVID. Consejero: EFDEZ BIENES SOCIEDAD LIMITADA. Presidente: EFDEZ BIENES SOCIEDAD LIMITADA. Consejero: FERNANDEZ VIAL...
Revocaciones — 29/05/2012
Revocaciones. Apo.Sol.: ROMERO ALVAREZ JACINTO. Datos registrales. T 4249 , F 69, S 8, H SE 64315, I/A 15 (14.05.12).
Nombramientos — 29/05/2012
Nombramientos. Apoderado: CARRANZA ALVAREZ JOSE CRISTOBAL. Datos registrales. T 4249 , F 69, S 8, H SE 64315, I/A 16 (16.05.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 100 Martes 29 de mayo de 2012 Pág. 24827 cve:...
Revocaciones — 18/11/2011
Revocaciones. Apo.Manc.: ALCALA GARCIA RAFAEL;MARTIN MENA MANUEL. Datos registrales. T 4249 , F 68, S 8, H SE 64315, I/A 13 ( 3.11.11).
Nombramientos — 18/11/2011
Nombramientos. Apo.Manc.: CARRANZA ALVAREZ JOSE CRISTOBAL;ALCALA GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 4249 , F 69, S 8, H SE 64315, I/A 14 ( 3.11.11).
Ceses/dimisiones — 15/11/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ VIAL GONZALEZ BARBA JOAQUIN. Vicepresid.: FERNANDEZ VIAL GONZALEZ BARBA JOAQUIN. Consejero: FERNANDEZ VIAL ENRIQUE;SOLIS MARTINEZ CAMPOS FERNANDO;FERNANDEZ VIAL JUAN BOSCO;RODRIGUE...
Nombramientos — 11/01/2010
Nombramientos. Apo.Manc.: ALCALA GARCIA RAFAEL;ALVAREZ CASTRO JOSE MIGUEL;BENITEZ RINCON DAVID. Datos registrales. T 4249 , F 67, S 8, H SE 64315, I/A 11 (21.12.09).
Ceses/dimisiones — 29/09/2009
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: URUÑUELA LOBERA MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: BENITEZ RINCON DAVID. Datos registrales. T 4249 , F 66, S 8, H SE 64315, I/A 10 (16.09.09).
Nombramientos — 29/06/2009
Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Datos registrales. T 4249 , F 66, S 8, H SE 64315, I/A 9 (17.06.09).