Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 3 tarjetas
20/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-118708

Nombramientos — 20/03/2015

Nombramientos. Apoderado: PRAXEDES GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 28674 , F 62, S 8, H M 411227, I/A 37 (11.03.15).

12/11/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-458090

Revocaciones — 12/11/2014

Revocaciones. Apo.Sol.: PAZO BEGINES JUAN JOSE. Apoderado: SUMARROCA CLAVEROL CARLES;PEREA SAMARRA FERNANDO;MARSA CASANELLAS ELISENDA;PALAIN PONT SERGIO;OLEART PLOMER ROMAN;CASTELLS SALVAT JOSEP;ROSELL SAGRERA RAFAEL;GA...

16/06/2010 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-239820

Ampliación de capital — 16/06/2010

Ampliación de capital. Capital: 22.425.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.425.000,00 Euros. Datos registrales. T 24886 , F 208, S 8, H M 411227, I/A 14 ( 4.06.10).