Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 5 tarjetas
07/01/2016 Sec. I Cambio de denominación social Barcelona
Barcelona-3913

Cambio de denominación social — 07/01/2016

Cambio de denominación social. COMSA APARCAMIENTOS SL. Datos registrales. T 44300 , F 173, S 8, H B 329000, I/A 20 (28.12.15).

02/10/2014 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-391841

Nombramientos — 02/10/2014

Nombramientos. APODERAD.SOL: PEREA SAMARRA FERNANDO;PONZ INGLES IGNACIO. Datos registrales. T 44300 , F 172, S 8, H B 329000, I/A 18 (25.09.14).

22/05/2014 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-213706

Nombramientos — 22/05/2014

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: SUMARROCA CLAVEROL CARLES;PEREA SAMARRA FERNANDO;OLEART PLOMER ROMAN;NAVARRO EZQUERRA ANA;BOSSA BUESO JORDI;CASTELLS SALVAT JOSEP;GARCIA MARC SILVIA. Datos registrales. T 42836 , F 49, S 8,...

09/01/2014 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-6014

Nombramientos — 09/01/2014

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42836 , F 49, S 8, H B 329000, I/A 16 (30.12.13).

16/12/2013 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-535470

Revocaciones — 16/12/2013

Revocaciones. APODERADO: TUR RIERA MARIA NIEVES;SUMARROCA CLAVEROL CARLES;DE LA FUENTE CANE FERNANDO;RODRIGUEZ PRIETO JOSE EUGENIO;VERDEJO DEL VALLE PEDRO;DE LA PLAZA GOMEZ ALBERTO;GARCIA DIEZ IGOR;MACHIN MEDINA SALVADO...