Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 22 tarjetas
02/08/2019 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-339251

Reelecciones — 02/08/2019

Reelecciones. Consejero: REY LAREDO JAVIER. Presidente: REY LAREDO JAVIER. Cons.Del.Sol: REY LAREDO JAVIER. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 216, S 8, H PO 9437, I/A 59 (24.07.19).

27/11/2017 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-465120

Reelecciones — 27/11/2017

Reelecciones. Consejero: DE PABLOS JUAN ANDRES. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 215, S 8, H PO 9437, I/A 58 (17.11.17).

02/11/2016 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-441397

Revocaciones — 02/11/2016

Revocaciones. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 214, S 8, H PO 9437, I/A 56 (24.10.16).

02/11/2016 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-441398

Nombramientos — 02/11/2016

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 214, S 8, H PO 9437, I/A 57 (24.10.16).

10/06/2016 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-247617

Reelecciones — 10/06/2016

Reelecciones. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 214, S 8, H PO 9437, I/A 55 ( 1.06.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 110 Viernes 10 de junio de 2016 Pág. 26783...

01/04/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-145576

Ceses/dimisiones — 01/04/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO LOPEZ IGNACIO. Cons.Del.Sol: ALONSO LOPEZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: LESAOLA RODRIGUEZ ALEJANDRO BENITO. Cons.Del.Sol: LESAOLA RODRIGUEZ ALEJANDRO BENITO. Datos registrales. T...

26/02/2016 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-89427

Revocaciones — 26/02/2016

Revocaciones. Apoderado: ALONSO LOPEZ IGNACIO. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 214, S 8, H PO 9437, I/A 53 (18.02.16).

04/11/2015 Sec. I Otros conceptos: Se modifica el artículo 7 de los Estatutos Sociales y se incorpora un nuevo artículo a los mismos, tras el artículo 8 , que se denominará artículo 8 BIS Pontevedra
Pontevedra-445300

Otros conceptos: se modifica el artículo 7 de los estatutos sociales y se incorpora un nuevo artículo a los mismos, tras el artículo 8 , que se denominará artículo 8 bis — 04/11/2015

Otros conceptos: Se modifica el artículo 7 de los Estatutos Sociales y se incorpora un nuevo artículo a los mismos, tras el artículo 8 , que se denominará artículo 8 BIS. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 213, S 8, H...

24/10/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-428513

Ceses/dimisiones — 24/10/2014

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: ALONSO LOPEZ IGNACIO;REY LAREDO JAVIER. Nombramientos. Cons.Del.Sol: REY LAREDO JAVIER;ALONSO LOPEZ IGNACIO. Reelecciones. Consejero: REY LAREDO JAVIER. Presidente: REY LAREDO JAVIER. Con...

20/12/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-545225

Ceses/dimisiones — 20/12/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: HUERTA NICOLAS JAVIER. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 213, S 8, H PO 9437, I/A 50 (13.12.13).

08/01/2013 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-7511

Revocaciones — 08/01/2013

Revocaciones. Apoderado: ESTEVEZ VAQUEIRO MANUEL. Apo.Sol.: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Apoderado: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 212, S 8, H PO 9437, I/A 49 (21.12.12).

19/10/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-427107

Ceses/dimisiones — 19/10/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 212, S 8, H PO 9437, I/A 47 ( 8.10.12).

21/08/2012 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-349185

Reelecciones — 21/08/2012

Reelecciones. Consejero: DE PABLOS JUAN ANDRES. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 212, S 8, H PO 9437, I/A 46 ( 2.08.12).

30/01/2012 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-45565

Reelecciones — 30/01/2012

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 211, S 8, H PO 9437, I/A 44 (19.01.12).

30/01/2012 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-45566

Nombramientos — 30/01/2012

Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 212, S 8, H PO 9437, I/A 45 (19.01.12).

29/08/2011 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-354524

Revocaciones — 29/08/2011

Revocaciones. Apoderado: SILBERSTEIN AGOSTINO HEBERT. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 210, S 8, H PO 9437, I/A 41 (17.08.11).

29/08/2011 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-354525

Nombramientos — 29/08/2011

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 210, S 8, H PO 9437, I/A 42 (17.08.11).

27/04/2011 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-184224

Reelecciones — 27/04/2011

Reelecciones. Consejero: HUERTA NICOLAS JAVIER;GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 210, S 8, H PO 9437, I/A 40 (13.04.11).

05/05/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-182155

Ceses/dimisiones — 05/05/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: CONSTRUCTORA SAN JOSE SA. Cons.Del.Sol: CONSTRUCTORA SAN JOSE SA. Consejero: GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA. Secretario: OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Vicesecret.: CAÑAS GARCIA-ROJO FEDERICO. Nomb...

25/03/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-147054

Ceses/dimisiones — 25/03/2009

Ceses/Dimisiones. Apoderado: FREIRE PEREZ RAUL. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 209, S 8, H PO 9437, I/A 37 (12.03.09).

29/01/2009 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-50198

Revocaciones — 29/01/2009

Revocaciones. Apo.Sol.: ZAFRA FERNANDEZ DE TEJADA MANUEL. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 209, S 8, H PO 9437, I/A 35 (19.01.09).

19/01/2009 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-26640

Nombramientos — 19/01/2009

Nombramientos. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Datos registrales. T 2874, L 2874, F 208, S 8, H PO 9437, I/A 34 (29.12.08).