Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 15 tarjetas
11/02/2019 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-62095

Cambio de domicilio social — 11/02/2019

Cambio de domicilio social. C/ PINAR NUMERO 5. EDIFICIO REGUS (MADRID). Datos registrales. T 34643 , F 120, S 8, H M 257959, I/A 57 ( 4.02.19).

10/08/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-334236

Revocaciones — 10/08/2018

Revocaciones. Apo.Sol.: CARREÑO GIL CRISTINA. Apoderado: FONSECA GARCIA CARO JUAN JOSE. Apo.Man.Soli: COLQUHOUN CAMPBELL COLIN JOHN;NAVARRO SANCHEZ-SICILIA JAIME;LOPEZ LUCAS RAQUEL;LIMETTI ROBERTO;EMANUELE STEFANIA;FONS...

09/02/2018 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-66354

Reelecciones — 09/02/2018

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 34643 , F 117, S 8, H M 257959, I/A 55 ( 2.02.18).

27/12/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-507121

Ceses/dimisiones — 27/12/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA LOPEZ JULIO. Vicesecret.: GARCIA LOPEZ JULIO. Consejero: BRUNET MORALES-ARCE ALFONSO. Presidente: BRUNET MORALES-ARCE ALFONSO. SecreNoConsj: PEREZ MAILLO RUBEN. Nombramientos. Conseje...

27/12/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-507122

Revocaciones — 27/12/2017

Revocaciones. Apo.Sol.: BUERGO MONTES AMELIA. Apoderado: GARCIA LOPEZ JULIO;BRUNET MORALES-ARCE ALFONSO;PEREZ MAILLO RUBEN. Apo.Man.Soli: FONSECA GARCIA CARO JUAN JOSE;COLQUHOUN CAMPBELL COLIN JOHN. Nombramientos. Apo.M...

22/12/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-519293

Ceses/dimisiones — 22/12/2016

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MAYNAU ICETA JAIME. Revocaciones. Apoderado: MAYNAU ICETA JAIME;MAYNAU ICETA JAIME. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ MAILLO RUBEN. Datos registrales. T 28673 , F 174, S 8, H M 257959, I...

06/08/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-328135

Revocaciones — 06/08/2015

Revocaciones. Apoderado: BURY JAMES ROBERT ANDREW. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAMPBELL COLIN JOHN COLQUHOUN. Datos registrales. T 28673 , F 173, S 8, H M 257959, I/A 51 (29.07.15).

05/08/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-326295

Ceses/dimisiones — 05/08/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: BURY JAMES ROBERT ANDREW. Vicepresid.: BURY JAMES ROBERT ANDREW. Nombramientos. Consejero: CAMPBELL COLIN JOHN COLQUHOUN. Con.Delegado: CAMPBELL COLIN JOHN COLQUHOUN. Datos registrales. T 28...

09/01/2014 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-7231

Reelecciones — 09/01/2014

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28673 , F 169, S 8, H M 257959, I/A 46 (30.12.13).

15/07/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-318864

Nombramientos — 15/07/2013

Nombramientos. Apoderado: FONSECA GARCIA CARO JUAN JOSE. Datos registrales. T 28673 , F 169, S 8, H M 257959, I/A 45 ( 5.07.13).

25/06/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-289587

Nombramientos — 25/06/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO CHAMORRO MARIA DEL CARMEN;CARREÑO GIL CRISTINA;DIAZ-MAROTO MARTINEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 28673 , F 169, S 8, H M 257959, I/A 44 (17.06.13).

20/03/2013 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-132567

Declaración de unipersonalidad — 20/03/2013

Declaración de unipersonalidad. Socio único: PRADERA HOLDCO SARL. Datos registrales. T 28673 , F 168, S 8, H M 257959, I/A 43 (11.03.13).

11/12/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-512290

Ceses/dimisiones — 11/12/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPBELL COLIN JOHN COLQUHOUN. Vicepresid.: CAMPBELL COLIN JOHN COLQUHOUN. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAMPBELL COLIN JOHN COLQUHOUN;GARCIA LOPEZ JULIO;BRUNET MORALES-ARCE ALFONSO;PEREZ MAIL...

16/01/2012 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-18571

Reelecciones — 16/01/2012

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28673 , F 166, S 8, H M 257959, I/A 38 ( 2.01.12).

04/06/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-255901

Nombramientos — 04/06/2009

Nombramientos. Apoderado: PERELLO SERRANO NOELIA. Datos registrales. T 25364 , F 206, S 8, H M 257959, I/A 33 (26.05.09).