Actos destacados
Ceses/dimisiones — 15/11/2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRO BLANCO ROLANDO. Presidente: CASTRO BLANCO ROLANDO. Con.Delegado: CASTRO BLANCO ROLANDO. Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ZAMORA MARCO VINICIO;VARGAS ALFARO CHASITY GEANNINA. Nombrami...
Nombramientos — 16/10/2018
Nombramientos. Con.Delegado: DIAZ RUBEN. Apoderado: DARQUEA SEVILLA ALFREDO FERNANDO;AGUILAR REVELO RAMON JAVIER. Datos registrales. T 34306 , F 222, S 8, H M 617162, I/A 8 ( 8.10.18).
Revocaciones — 10/04/2018
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ ZAMORA MARCO VINICIO;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;DOMINGUEZ HUELAMO NATALIA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;DOMINGUEZ HUELAMO NATALIA;CARRASCAL ALONSO AURORA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;DOMING...
Nombramientos — 02/12/2016
Nombramientos. Apoderado: GALLEGOS ECHEVARRIA FERNAN. Datos registrales. T 34306 , F 221, S 8, H M 617162, I/A 6 (22.11.16).
Otros conceptos: subsanación de la inscripción 2ª en cuanto al nif español del socio unico, siendo el correcto n0039419g y no n0182937c — 27/07/2016
Otros conceptos: Subsanación de la inscripción 2ª en cuanto al NIF español del Socio Unico, siendo el correcto N0039419G y no N0182937C.- Datos registrales. T 34306 , F 221, S 8, H M 617162, I/A 5 (18.07.16).
Nombramientos — 22/07/2016
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ZAMORA MARCO VINICIO;GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;DOMINGUEZ HUELAMO NATALIA;SAEZ SERRANO SARA;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;HERNANDEZ HERN...