Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 19 tarjetas
05/12/2019 Sec. I Extinción Madrid
Madrid-504120

Extinción — 05/12/2019

Extinción. Datos registrales. T 32007 , F 225, S 8, H M 381079, I/A 81 (28.11.19).

12/11/2019 Sec. I Otros conceptos: A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 231 DEL RRM Y EN RELACION A LA SOCIEDAD " CODELCO MERCANTIL SA " , SE HACE CONSTAR LA INEXISTENCIA DE OBSTACULO REGISTRAL PARA LA INSCRIPCION DE LA ABSORCION DE LA MISMA POR LA ENTIDAD DOMICILIADA EN BILBAO DENOMINADA "EULEN SA " Madrid
Madrid-466871

Otros conceptos: a efectos de lo dispuesto en el articulo 231 del rrm y en relacion a la sociedad " codelco mercantil sa " , se hace constar la inexistencia de obstaculo registral para la inscripcion de la absorcion de la misma por la entidad domiciliada en bilbao denominada "eulen sa " — 12/11/2019

Otros conceptos: A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 231 DEL RRM Y EN RELACION A LA SOCIEDAD " CODELCO MERCANTIL SA " , SE HACE CONSTAR LA INEXISTENCIA DE OBSTACULO REGISTRAL PARA LA INSCRIPCION DE LA ABSORCION DE...

11/04/2019 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-163850

Reelecciones — 11/04/2019

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32007 , F 225, S 8, H M 381079, I/A 80 ( 4.04.19).

11/03/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-110746

Nombramientos — 11/03/2019

Nombramientos. Apo.Sol.: ARROYO SOUTO MANUEL. Datos registrales. T 32007 , F 224, S 8, H M 381079, I/A 79 ( 4.03.19).

08/11/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-447778

Nombramientos — 08/11/2018

Nombramientos. Apoderado: COLLAR SOTERES ELENA. Datos registrales. T 32007 , F 224, S 8, H M 381079, I/A 78 (31.10.18).

08/03/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-110246

Cambio de domicilio social — 08/03/2018

Cambio de domicilio social. C/ GOBELAS 29 (MADRID). Datos registrales. T 32007 , F 223, S 8, H M 381079, I/A 75 (23.02.18).

15/01/2018 Sec. I Otros conceptos: Queda revocado el poder conferido a DON JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ que causó la inscripción 1ª en la hoja social del Registro Mercantil de Madrid Madrid
Madrid-19184

Otros conceptos: queda revocado el poder conferido a don jose manuel fernandez alvarez que causó la inscripción 1ª en la hoja social del registro mercantil de madrid — 15/01/2018

Otros conceptos: Queda revocado el poder conferido a DON JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ que causó la inscripción 1ª en la hoja social del Registro Mercantil de Madrid. Datos registrales. T 32007 , F 222, S 8, H M 381079,...

15/01/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-19185

Revocaciones — 15/01/2018

Revocaciones. Apoderado: CAVERO CATALAN OSCAR. Datos registrales. T 32007 , F 222, S 8, H M 381079, I/A 73 ( 5.01.18).

10/03/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-113681

Revocaciones — 10/03/2016

Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID. Datos registrales. T 32007 , F 220, S 8, H M 381079, I/A 66 ( 3.03.16).

18/02/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-73366

Reelecciones — 18/02/2016

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32007 , F 220, S 8, H M 381079, I/A 65 ( 9.02.16).

12/11/2015 Sec. I Otros conceptos: DON PEDRO PARES RON RENUNCIA A LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 45& DE LA HOJA ABIERTA A LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA Madrid
Madrid-455796

Otros conceptos: don pedro pares ron renuncia a los poderes que le fueron conferidos mediante escritura que causo la inscripcion 45& de la hoja abierta a la sociedad en el registro mercantil de barcelona — 12/11/2015

Otros conceptos: DON PEDRO PARES RON RENUNCIA A LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 45& DE LA HOJA ABIERTA A LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA. Datos registra...

08/09/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-366728

Nombramientos — 08/09/2015

Nombramientos. Apo.Man.Soli: YAÑEZ SEBASTIAN MABEL-MONICA. Datos registrales. T 32007 , F 218, S 8, H M 381079, I/A 63 (27.08.15).

07/08/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-330191

Revocaciones — 07/08/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BORREGON BAÑOS JUAN PABLO. Datos registrales. T 32007 , F 218, S 8, H M 381079, I/A 62 (30.07.15).

07/04/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-144400

Revocaciones — 07/04/2015

Revocaciones. Apoderado: GORDON GARCIA SALCEDO ALFONSO. Datos registrales. T 32007 , F 216, S 8, H M 381079, I/A 58 (27.03.15).

13/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-109908

Nombramientos — 13/03/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS. Apo.Manc.: MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS;SALAZAR ROMAN ANTONIO MIGUEL. Apo.Sol.: SALAZAR ROMAN ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T 32007 , F 214, S 8, H M 381079, I...

21/06/2013 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-285123

Declaración de unipersonalidad — 21/06/2013

Declaración de unipersonalidad. Socio único: EULEN SA. Ceses/Dimisiones. Secretario: CARRERO ANTIN SANTIAGO. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Con.Delegado: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA J...

29/05/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-227032

Nombramientos — 29/05/2012

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SUAREZ GONZALEZ ISIDRO. Datos registrales. T 27744 , F 215, S 8, H M 381079, I/A 43 (16.05.12).

08/03/2010 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-98241

Revocaciones — 08/03/2010

Revocaciones. Apo.Man.Soli: PATRICIO DOMINGUEZ JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 27084 , F 79, S 8, H M 381079, I/A 29 (25.02.10).

01/03/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-86116

Nombramientos — 01/03/2010

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO FERNANDEZ ISMAEL. Datos registrales. T 27084 , F 77, S 8, H M 381079, I/A 28 (17.02.10).