Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 22 tarjetas
12/01/2017 Sec. I Transformación de sociedad Madrid
Madrid-14382

Transformación de sociedad — 12/01/2017

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: COCA-COLA IBERIAN PARTNERS SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ VILA ALBERTO;PEREZ NIVELA ISABELA;COSANO JORDA FRANCISCO;LAVINDER JOYCE MARIE KING. Presidente...

19/09/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-379796

Nombramientos — 19/09/2016

Nombramientos. Apo.Man.Soli: JYHANGIANI MANIK HIRU;LAVINDER JOYCE MARIE KING. Apo.Manc.: PEREZ VILA ALBERTO;COSANO JORDA FRANCISCO;RUFART GARCIA VICTOR;AMENEDO FERREIRO FERNANDO;SARMENTO VINHAS BOLETÍN OFICIAL DEL REGIS...

13/09/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-374265

Ceses/dimisiones — 13/09/2016

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OLIVE PARTNERS SA. Representan: COSANO JORDA FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: COSANO JORDA FRANCISCO. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 32531 , F 184, S 8, H M 546165, I/...

27/05/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-226743

Nombramientos — 27/05/2016

Nombramientos. Apo.Sol.: MADURGA RIVERA GONZALO. Datos registrales. T 32531 , F 183, S 8, H M 546165, I/A 54 (19.05.16).

27/05/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-226744

Revocaciones — 27/05/2016

Revocaciones. Apo.Sol.: CERDA SANCHEZ DE LEON ALEJANDRO;COVA ALONSO ABRAHAM. Apo.Man.Soli: DE TORO RODRIGUEZ EDUARDO. Datos registrales. T 32531 , F 183, S 8, H M 546165, I/A 55 (20.05.16).

05/01/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-2633

Ceses/dimisiones — 05/01/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: DAURELLA COMADRAN SOL;MONTSUNT SA;ROTLLANT SOLA MARIO;LARFIN SA;COBEGA INVEST SL;COLABOTS SL;EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VALENCIANAS SL;VALVEGA SL;MENDIBEA 2002 SL. Presidente: DAURE...

02/12/2015 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-488676

Modificaciones estatutarias — 02/12/2015

Modificaciones estatutarias. 8. - TRANSMISION DE LAS ACCIONES . - . . . . . 8.3 Transmisiones Permitidas. . . . . (ii). . . -. Datos registrales. T 32531 , F 172, S 8, H M 546165, I/A 48 (25.11.15).

24/11/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-474868

Nombramientos — 24/11/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: BALLESTEROS GONZALEZ ALFREDO. Apo.Man.Soli: YAGUE MARTINEZ ROSA;AGUIRREGOMEZCORTA CONTRERAS CARLOS;GALL VERDAGUER FERRAN. Datos registrales. T 32531 , F 170, S 8, H M 546165, I/A 46 (16.11.15).

24/11/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-474869

Revocaciones — 24/11/2015

Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ DE CEPEDA CARLOS. Datos registrales. T 32531 , F 172, S 8, H M 546165, I/A 47 (16.11.15).

23/11/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-472627

Nombramientos — 23/11/2015

Nombramientos. Apoderado: ROZAS ESTOR ISRAEL;BARAZA GONZALEZ FERRAN. Datos registrales. T 32531 , F 169, S 8, H M 546165, I/A 44 (12.11.15).

23/11/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-472628

Nombramientos — 23/11/2015

Nombramientos. Apoderado: COSANO JORDA FRANCISCO;GALL VERDAGUER FERRAN;ARTEAGA DAÑOBEITIA AITOR;PEREZ DE AYALA TRILL EDUARDO;PEREZ VILA ALBERTO;MOLINA HERREZUELO EUGENIO;SANCHEZ DE TORO ANTONIO;SERRANO TUBIO RAFAEL;AGUI...

17/08/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-340733

Nombramientos — 17/08/2015

Nombramientos. Apoderado: ECHEVERRIA VILLAR JOSE ANTONIO;PEREZ PUENTE MIGUEL ANGEL;AGUILERA ORTEGA JOSE MANUEL;SANCHEZ GANDARIAS FRANCISCO JAVIER;GIMENO ANGUELU JOSE-VICENTE;ESPINA SOLE ANNA MARIA;BATET SERRA NURIA;MEND...

17/08/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-340734

Nombramientos — 17/08/2015

Nombramientos. Apoderado: GALLEGO MIGUEZ LORENA. Datos registrales. T 32531 , F 167, S 8, H M 546165, I/A 42 (30.07.15).

06/08/2015 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-328101

Modificaciones estatutarias — 06/08/2015

Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 5, 14, 16, 21, 24, 25 y 27. Datos registrales. T 32531 , F 164, S 8, H M 546165, I/A 40 (29.07.15).

23/07/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-304833

Ceses/dimisiones — 23/07/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: BILBAINA DE INVERSION Y CONTROL SL. Representan: AZNAR SAINZ ALEJANDRO. Nombramientos. Representan: CASTELLANOS BORREGO JAIME. Consejero: PAOSAR SL. Datos registrales. T 32531 , F 162, S 8,...

14/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-287963

Revocaciones — 14/07/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: LECHUGA CISNEROS RICARDO;LECHUGA CISNEROS RICARDO. Nombramientos. Apoderado: MOLINA HERREZUELO EUGENIO. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a don Ignacio Gonzalez Lopez de Lemus en l...

14/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-287964

Nombramientos — 14/07/2015

Nombramientos. Apoderado: AMENEDO FERREIRO FERNANDO;SARMENTO VINHAS PEDRO ALEXANDRE;MOLINA HERREZUELO EUGENIO. Datos registrales. T 32531 , F 161, S 8, H M 546165, I/A 37 ( 6.07.15).

22/01/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-27373

Revocaciones — 22/01/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE;LANZAGORTA CASANS JOSE MIGUEL;RAMONELL RIO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 32531 , F 157, S 8, H M 546165, I/A 31 (14.01.15).

15/07/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-291462

Nombramientos — 15/07/2014

Nombramientos. Apo.Sol.: VILA VARELA CARLOS;BARAZA GONZALEZ FERRAN;ROZAS ESTOR ISRAEL. Datos registrales. T 30709 , F 113, S 8, H M 546165, I/A 25 ( 4.07.14).

18/06/2013 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-278106

Ampliación de capital — 18/06/2013

Ampliación de capital. Suscrito: 1.517.000.000,00 Euros. Desembolsado: 1.517.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.517.060.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.517.060.000,00 Euros. Cambio de domicilio social. PA...

18/06/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-278107

Nombramientos — 18/06/2013

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30709 , F 106, S 8, H M 546165, I/A 10 (11.06.13).

18/04/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-183583

Nombramientos — 18/04/2013

Nombramientos. Apoderado: RUFART GARCIA VICTOR. Datos registrales. T 30709 , F 93, S 8, H M 546165, I/A 5 ( 9.04.13).