Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2014 20 tarjetas
27/02/2014 Sec. I Disolución Sevilla
Sevilla-93462

Disolución — 27/02/2014

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 5758 , F 51, S 8, H SE 37360, I/A 47 (19.02.14).

22/01/2014 Sec. I Otros conceptos: Extendida con fecha 14 de enero de 2014, nota de cierre provisional a que se refiere el artículo 231 del R Sevilla
Sevilla-29395

Otros conceptos: extendida con fecha 14 de enero de 2014, nota de cierre provisional a que se refiere el artículo 231 del r — 22/01/2014

Otros conceptos: Extendida con fecha 14 de enero de 2014, nota de cierre provisional a que se refiere el artículo 231 del R.R.M., por haber sido absorbida, en unión de otras no pertenecientes a esta demarcación registra...

29/11/2013 Sec. I Nombramientos Sevilla
Sevilla-511670

Nombramientos — 29/11/2013

Nombramientos. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5758 , F 51, S 8, H SE 37360, I/A 46 (21.11.13).

31/10/2013 Sec. I Revocaciones Sevilla
Sevilla-466661

Revocaciones — 31/10/2013

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ SEXMA PABLO. Datos registrales. T 5261 , F 217, S 8, H SE 37360, I/A 44 (23.10.13).

31/10/2013 Sec. I Nombramientos Sevilla
Sevilla-466662

Nombramientos — 31/10/2013

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LIMON MARIA ALEJANDRA. Datos registrales. T 5261 , F 217, S 8, H SE 37360, I/A 45 (23.10.13).

24/07/2013 Sec. I Revocaciones Sevilla
Sevilla-332955

Revocaciones — 24/07/2013

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE ZULUETA GREENEBAUM JOHN;DE ALVARO REGUERA FRANCISCO;VILLARINO MARZO MARIA DEL PILAR;TRUJILLO CASAS JUAN RICARDO;BARREIRO HERNANDEZ MERCEDES;JUARROS ALCALDE MARIA JOSE. Datos registrales. T...

04/02/2013 Sec. I Nombramientos Sevilla
Sevilla-55085

Nombramientos — 04/02/2013

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5261 , F 216, S 8, H SE 37360, I/A 42 (23.01.13).

12/03/2012 Sec. I Revocaciones Sevilla
Sevilla-118340

Revocaciones — 12/03/2012

Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOSANTOS BONETA LUIS GERMAN;ROBERT LEWIS GRAEME. Datos registrales. T 5261 , F 215, S 8, H SE 37360, I/A 39 (24.02.12).

27/01/2012 Sec. I Reelecciones Sevilla
Sevilla-43454

Reelecciones — 27/01/2012

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5261 , F 214, S 8, H SE 37360, I/A 38 (18.01.12).

18/11/2011 Sec. I Revocaciones Sevilla
Sevilla-459749

Revocaciones — 18/11/2011

Revocaciones. Apo.Man.Soli: FUENTES RODRIGUEZ JOSE CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ SEXMA PABLO. Datos registrales. T 5256 , F 87, S 8, H SE 37360, I/A 36 ( 7.11.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL...

18/11/2011 Sec. I Nombramientos Sevilla
Sevilla-459750

Nombramientos — 18/11/2011

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANELO PINILLA CAYETANO. Datos registrales. T 5256 , F 89, S 8, H SE 37360, I/A 37 ( 7.11.11).

30/08/2011 Sec. I Nombramientos Sevilla
Sevilla-356138

Nombramientos — 30/08/2011

Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUARROS ALCALDE MARIA JOSE. Datos registrales. T 5256 , F 85, S 8, H SE 37360, I/A 35 (18.08.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 165 Martes 30 de agosto de 2011 Pág. 45256 cve:...

28/06/2011 Sec. I Reelecciones Sevilla
Sevilla-273132

Reelecciones — 28/06/2011

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5256 , F 83, S 8, H SE 37360, I/A 33 ( 7.06.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 122 Martes 28 de junio de 2011 Pág. 32640 cve: BORME-A-2011-122...

28/06/2011 Sec. I Revocaciones Sevilla
Sevilla-273133

Revocaciones — 28/06/2011

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MATEOS GARCIA RICARDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROBERT LEWIS GRAEME;TRUJILLO CASAS JUAN RICARDO;BARREIRO HERNANDEZ MERCEDES;USON JAEGER PATRICIA ELISABETH;RICO PEREZ PEDRO CANDIDO. Datos...

18/01/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Sevilla
Sevilla-18915

Ceses/dimisiones — 18/01/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: USP HOSPITALES SL. Con.Delegado: USP HOSPITALES SL. Consejero: BERRA DE UNAMUNO RAMON;DE ALVARO REGUERA FRANCISCO. Presidente: DE ALVARO REGUERA FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: USP HOS...

29/11/2010 Sec. I Revocaciones Sevilla
Sevilla-441103

Revocaciones — 29/11/2010

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROMERO JIMENEZ OSCAR;BERRA DE UNAMUNO RAMON;MATEOS GARCIA RICARDO;JIMENEZ DE LAS HERAS GEMMA;CABRERA AYALA JOSE LUIS;SERRANO MOYA MARIA DEL PILAR;FUENTES RODRIGUEZ JOSE CARLOS. Nombramientos....

16/08/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Sevilla
Sevilla-321271

Ceses/dimisiones — 16/08/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: PRAT DOMENECH JOSE. Presidente: PRAT DOMENECH JOSE. Secretario: BERRA DE UNAMUNO RAMON. Nombramientos. Consejero: DE ALVARO REGUERA FRANCISCO. SecreNoConsj: MILLAN FERNANDEZ ISAAC. President...

25/06/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Sevilla
Sevilla-254732

Ceses/dimisiones — 25/06/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: MASFURROLL LACAMBRA GABRIEL. Presidente: MASFURROLL LACAMBRA GABRIEL. Vicepresid.: JORGE NEBOT MARIA SOLEDAD. Consejero: JORGE NEBOT MARIA SOLEDAD. Secretario: CALVO DEL MOLINO JUAN PEDRO. N...

01/06/2010 Sec. I Fe de erratas: MONTE CANDINA SL, CAMBIO SU DENOMINACION POR LA DE "USP HOSPITALES SL" Sevilla
Sevilla-218900

Fe de erratas: monte candina sl, cambio su denominacion por la de "usp hospitales sl" — 01/06/2010

Fe de erratas: MONTE CANDINA SL, CAMBIO SU DENOMINACION POR LA DE "USP HOSPITALES SL". Datos registrales. T 3937 , F 202, S 8, H SE 37360, I/A 21 (20.10.09).

12/03/2010 Sec. I Sociedad unipersonal Sevilla
Sevilla-106512

Sociedad unipersonal — 12/03/2010

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: USP HOSPITALES SL. Datos registrales. T 3937 , F 205, S 8, H SE 37360, I/A 25 (25.02.10).