Actos destacados
Disolución — 13/03/2014
Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 9707, L 6989, F 101, S 8, H V 143937, I/A 39 ( 6.03.14).
Nombramientos — 05/12/2013
Nombramientos. Apoderado: PROMONTORIA PLATAFORMA SL. Datos registrales. T 9569, L 6851, F 153, S 8, H V 143937, I/A 38 (28.11.13).
Ceses/dimisiones — 08/11/2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Solid.: BRIS PERTIÑEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 9569, L 6851, F 153, S 8, H V 143937, I/A 37 (31.10.13).
Revocaciones — 02/09/2013
Revocaciones. Apoderado: BROTO VENTURA SARA ELENA;CARLES ALTUR CONSUELO;SOLERO VAZQUEZ JOSE ANTONIO;MARTINEZ MICHAVILA MARIA DOLORES;PEREZ GONZALEZ TOMAS;MARTI PALANCA DESAMPARADOS;MARTIN LOPEZ MARIA CRISTINA;BENAVIDES...
Revocaciones — 02/09/2013
Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ JESUS LUISA CONSUELO. Datos registrales. T 9569, L 6851, F 152, S 8, H V 143937, I/A 35 (26.08.13).
Otros conceptos: de rectificación de la inscripción 1&, en cuanto a la inclusión en el anexo "anexo i — 09/08/2013
Otros conceptos: De rectificación de la inscripción 1&, en cuanto a la inclusión en el anexo "Anexo I.4 RESTO DE TERRENOS" de inmuebles integrantes de la unidad económica transferida a las beneficiaria que no se incluye...
Nombramientos — 04/06/2013
Nombramientos. Apoderado: BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS;VIDAL TERUEL ANTONIO-ABAD;HERRANZ RUBIO JUAN CARLOS;SANTAMARIA GARRIDO RICARDO RUBEN;SANCHEZ MENA JOSE JAVIER;YAGO GALVAN FRANCISCO;VILLALOBOS VILLAREJO MARIA DEL...
Nombramientos — 03/06/2013
Nombramientos. Apo.Sol.: BARTOLOME PASARO JUAN MARTIN;ZAFRA JIMENEZ ANTONIO;ORTOLA FAYOS JOSE;MUÑOZ HERNANDEZ ISRAEL JOSE;FERNANDEZ MAS ALEJANDRO;VIDAL TERUEL ANTONIO-ABAD;SANTAMARIA GARRIDO RICARDO RUBEN. Datos registr...
Revocaciones — 03/04/2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARGALEF GIL MONICA. Datos registrales. T 9569, L 6851, F 141, S 8, H V 143937, I/A 20 (25.03.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 62 Miércoles 3 de abril de 2013 Pág. 16476 cve:...
Revocaciones — 19/03/2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ CLEMENTE FERNANDO. Datos registrales. T 9569, L 6851, F 141, S 8, H V 143937, I/A 18 (11.03.13).
Revocaciones — 19/03/2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CODOÑER SEGUI RAFAEL TOMAS. Datos registrales. T 9569, L 6851, F 141, S 8, H V 143937, I/A 19 (11.03.13).
Revocaciones — 13/03/2013
Revocaciones. Apoderado: DEPARTAMENTOS DE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD LI. Datos registrales. T 9569, L 6851, F 141, S 8, H V 143937, I/A 17 ( 6.03.13).
Nombramientos — 22/02/2013
Nombramientos. Apo.Sol.: YAGO GALVAN FRANCISCO;CAUDELI GARCIA DAVID;BENAVIDES FERRER MARIA AMPARO;LOPEZ SAMPER MARIA DEL CARMEN;ROIG TIO MANUEL. Datos registrales. T 9333, L 6615, F 11, S 8, H V 143937, I/A 16 (15.02.13...
Revocaciones — 04/02/2013
Revocaciones. Apo.D.Gral.: MARCO AGUILAR VICENTE. Datos registrales. T 9333, L 6615, F 11, S 8, H V 143937, I/A 15 (28.01.13).
Ceses/dimisiones — 28/11/2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ENCINA LOS MONTEROS SL;BANKIA HABITAT SL. Nombramientos. Adm. Solid.: BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS;MARTIN MACHO ANTONIO EMILIO. Otros conceptos: Modificar los artículos 12, 14 y 16 de lo...
Otros conceptos: de rectificación de la inscripción 1&, en cuanto a la inclusión en el anexo "anexo i — 28/11/2012
Otros conceptos: De rectificación de la inscripción 1&, en cuanto a la inclusión en el anexo "Anexo I.4 RESTO DE TERRENOS" de inmuebles integrantes de la unidad económica transferida a las beneficiaria que no se incluye...
Otros conceptos: de rectificación de la inscripción 1&, en cuanto a la inclusión de dos anexos: el anexo i — 21/06/2012
Otros conceptos: De rectificación de la inscripción 1&, en cuanto a la inclusión de dos Anexos: El Anexo I.3 y I.4 y Anexo II.3 y II.4. Datos registrales. T 9333, L 6615, F 10, S 8, H V 143937, I/A 11 (12.06.12).
Revocaciones — 26/03/2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CORTINA ORRIOS JOSE. Datos registrales. T 9333, L 6615, F 9, S 8, H V 143937, I/A 10 (14.03.12).
Nombramientos — 24/11/2011
Nombramientos. Apoderado: GINER CARBONELL JORGE. Datos registrales. T 9333, L 6615, F 8, S 8, H V 143937, I/A 6 (15.11.11).
Nombramientos — 15/07/2011
Nombramientos. Apoderado: SALVADOR TREGON JORGE;GOMEZ VILLALBA JUAN JOSE;CESPEDES VILLEN PILAR;BORDERIA NAVARRO ADRIAN;RODRIGUEZ TORRES ANGEL;AYONG BOTET ANA CONCHIN;ALABADI FERRER SANTIAGO;ALEIXANDRE LLUESMA EMILIA MAR...
Nombramientos — 20/06/2011
Nombramientos. Apoderado: ROIG TIO MANUEL;COMES ROSADO MARIA ANGELES;MUNERA BAUTISTA ENRIQUE;CAMPOS FORES RAQUEL;MARCO AGUILAR JORGE;AGUILAR OLIVER BEATRIZ;INGLES BALAGUER BARTOLOME;BERTO BOU MIGUEL;FERNANDEZ MICO JUAN...
Nombramientos — 20/06/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CODOÑER SEGUI RAFAEL TOMAS;CORTINA ORRIOS JOSE;SANTOS BUENO MIGUEL ANGEL;DOLZ GARCIA JULIAN;LOPEZ CLEMENTE FERNANDO;MARGALEF GIL MONICA;SANTAMARIA GARRIDO RICARDO RUBEN;MARTINEZ ATIENZA CACH...
Nombramientos — 20/06/2011
Nombramientos. Apoderado: DEPARTAMENTOS DE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD LI. Datos registrales. T 9333, L 6615, F 8, S 8, H V 143937, I/A 4 ( 9.06.11).
Constitución — 17/06/2011
Constitución. Comienzo de operaciones: 7.06.11. Objeto social: La sociedad tiene por objeto la realización de actividades inmobiliarias en general, comprendiendo la adquisición, promoción, construcción explotación y ena...