Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 14 tarjetas
21/11/2016 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-470009

Revocaciones — 21/11/2016

Revocaciones. Apoderado: ROSELL MARTINEZ MARIA LUISA. Apo.Sol.: ARAUJO SALMERON JOAQUIN. Apoderado: CALLEJAS CACHERO ALFONSO;BRADFIELD TIMOTHY;SANGROS GONZALEZ ERNESTO;MORALES FACERIAS ALBERTO. Extinción. Datos registra...

29/12/2015 Sec. I Otros conceptos: Ha sido nombrada Doña Veronique Maria Iréne Huyghe, como representante de la Sociedad "GENERAL OTORS EUROPE HOLDING, S Zaragoza
Zaragoza-528569

Otros conceptos: ha sido nombrada doña veronique maria iréne huyghe, como representante de la sociedad "general otors europe holding, s — 29/12/2015

Otros conceptos: Ha sido nombrada Doña Veronique Maria Iréne Huyghe, como representante de la Sociedad "GENERAL OTORS EUROPE HOLDING, S.L.", en sustitución del anterior Don Carlos Pérez Francés. Datos registrales. T 410...

29/12/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-528570

Nombramientos — 29/12/2015

Nombramientos. Apoderado: BRADFIELD TIMOTHY. Datos registrales. T 4101 , F 199, S 8, H Z 58249, I/A 6 (21.12.15).

29/12/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-528571

Nombramientos — 29/12/2015

Nombramientos. Apoderado: SANGROS GONZALEZ ERNESTO. Datos registrales. T 4101 , F 199, S 8, H Z 58249, I/A 7 (21.12.15).

29/12/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-528572

Nombramientos — 29/12/2015

Nombramientos. Apoderado: MORALES FACERIAS ALBERTO. Datos registrales. T 4101 , F 200, S 8, H Z 58249, I/A 8 (21.12.15).

29/12/2015 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-528573

Revocaciones — 29/12/2015

Revocaciones. Apoderado: DEL RIO MARRERO FERNANDO. Datos registrales. T 4101 , F 200, S 8, H Z 58249, I/A 9 (21.12.15).

12/05/2015 Sec. I Cambio de domicilio social Zaragoza
Zaragoza-193645

Cambio de domicilio social — 12/05/2015

Cambio de domicilio social. POLIG ENTRERRIOS (FIGUERUELAS). Datos registrales. T 4101 , F 198, S 8, H Z 58249, I/A 2 ( 4.05.15).

12/05/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-193646

Nombramientos — 12/05/2015

Nombramientos. Apoderado: SUERO VALENZUELA AURELIO. Datos registrales. T 4101 , F 198, S 8, H Z 58249, I/A 3 ( 4.05.15).

12/05/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-193647

Nombramientos — 12/05/2015

Nombramientos. Apoderado: ROSELL MARTINEZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 4101 , F 199, S 8, H Z 58249, I/A 4 ( 4.05.15).

17/09/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-369978

Nombramientos — 17/09/2014

Nombramientos. Apo.Manc.: LUMBRERAS MATA JUAN MANUEL;DEL RIO MARRERO FERNANDO. Datos registrales. T 17884 , F 224, S 8, H M 135082, I/A 50 ( 9.09.14).

16/09/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-368390

Ceses/dimisiones — 16/09/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL RIO MARRERO FERNANDO;CALLEJAS CACHERO ALFONSO. Con.Delegado: DEL RIO MARRERO FERNANDO. Secretario: DEL RIO MARRERO FERNANDO. Con.Delegado: LUMBRERAS MATA JUAN MANUEL. Consejero: LUMBRERA...

07/11/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-457380

Revocaciones — 07/11/2012

Revocaciones. Apoderado: SAN ROMAN GARCIA JULIO. Apo.Sol.: MULAS JIMENEZ ALBERTO JOSE. Datos registrales. T 17884 , F 221, S 8, H M 135082, I/A 46 (25.10.12).

18/12/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-526358

Ceses/dimisiones — 18/12/2009

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: LOPEZ CHALEZQUER RICARDO. Consejero: LOPEZ CHALEZQUER RICARDO. Nombramientos. Consejero: DEL RIO MARRERO FERNANDO. Datos registrales. T 17884 , F 218, S 8, H M 135082, I/A 38 ( 3.12.09).

05/10/2009 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-418547

Reelecciones — 05/10/2009

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 17884 , F 218, S 8, H M 135082, I/A 37 (23.09.09).