Actos destacados
Nombramientos — 23/05/2017
Nombramientos. Apo.Sol.: ALARCON LUQUE RICARDO ALVARO;GREGORIO ARJONA PINTO;ROSILLO REIN ISABEL;FERNANDEZ CAMPOS MARIA. Datos registrales. T 5597, L 4504, F 159, S 8, H MA 10510, I/A 29 (12.05.17).
Fusión por absorción — 09/03/2017
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: FRIALDIS SL. FRIO PANDION SL. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 70, S 8, H MA 10510, I/A 28 (24.02.17).
Declaración de unipersonalidad — 22/02/2017
Declaración de unipersonalidad. Socio único: LUDOBOPA SL. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 70, S 8, H MA 10510, I/A 27 (10.02.17).
Nombramientos — 13/04/2016
Nombramientos. Apoderado: DE TORRES PEREZ DOMINGO. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 69, S 8, H MA 10510, I/A 25 ( 1.04.16).
Nombramientos — 13/04/2016
Nombramientos. Apoderado: DE TORRES ATENCIA LOURDES ROSARIO. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 69, S 8, H MA 10510, I/A 26 ( 1.04.16).
Ceses/dimisiones — 24/02/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE TORRES PEREZ DOMINGO. Presidente: DE TORRES PEREZ DOMINGO. Consejero: DE TORRES ATENCIA BORJA. Vicepresid.: DE TORRES ATENCIA BORJA. Cons.Del.Sol: DE TORRES PEREZ DOMINGO;DE TORRES ATENCI...
Nombramientos — 07/12/2015
Nombramientos. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 68, S 8, H MA 10510, I/A 23 (27.11.15).
Cambio de domicilio social — 01/09/2015
Cambio de domicilio social. C/ CASTELAO 2 - POLIGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE, L (MALAGA). Datos registrales. T 4922, L 3830, F 68, S 8, H MA 10510, I/A 22 (24.08.15).
Nombramientos — 14/01/2015
Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 67, S 8, H MA 10510, I/A 21 ( 5.01.15).
Nombramientos — 29/05/2013
Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 67, S 8, H MA 10510, I/A 18 (21.05.13).
Ceses/dimisiones — 29/05/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE TORRES ATENCIA LOURDES. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 67, S 8, H MA 10510, I/A 19 (21.05.13).
Revocaciones — 29/05/2013
Revocaciones. Apoderado: DE TORRES ATENCIA LOURDES ROSARIO. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 67, S 8, H MA 10510, I/A 20 (21.05.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 99 Miércoles 29 de mayo de 2013 Pág. 2...
Nombramientos — 26/04/2013
Nombramientos. Apoderado: DE TORRES PEREZ DOMINGO. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 67, S 8, H MA 10510, I/A 17 (17.04.13).
Cambio de objeto social — 28/12/2011
Cambio de objeto social. 1.La adquisición y transmisión de toda clase de acciones y Participacionessociales de todo tipo de compañías de forma directa e indirecta.Y elcontrolgestión y administración de valores represent...
Nombramientos — 21/10/2011
Nombramientos. Apoderado: DE TORRES ATENCIA LOURDES ROSARIO. Datos registrales. T 4922, L 3830, F 65, S 8, H MA 10510, I/A 14 (10.10.11).
Ceses/dimisiones — 21/09/2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE TORRES PEREZ DOMINGO. Nombramientos. Secretario: VASSEROT ANTON PEDRO. Consejero: DE TORRES PEREZ DOMINGO. Presidente: DE TORRES PEREZ DOMINGO. Consejero: DE TORRES ATENCIA BORJA. Vicepr...
Reducción de capital — 31/01/2011
Reducción de capital. Importe reducción: 10,04 Euros. Resultante Suscrito: 498.830,00 Euros. Otros conceptos: MODIFICACION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES POR LOS QUE SERIGE LA SOCIEDAD.- Datos registrales. T 2057, L 97...
Cambio de domicilio social — 02/12/2009
Cambio de domicilio social. C/ CASTELAO 9 - POLIGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE (MALAGA). Datos registrales. T 2057, L 970, F 58, S 8, H MA 10510, I/A 11 (20.11.09).