Actos destacados
Disolución — 26/12/2012
Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 638 , F 190, S 8, H LO 11222, I/A 27nm (18.12.12).
Revocaciones — 18/10/2012
Revocaciones. Apoderado: RUIZ LOPEZ ANGEL ANTONIO. Datos registrales. T 638 , F 190, S 8, H LO 11222, I/A 27 ( 8.10.12).
Ampliación de capital — 23/01/2012
Ampliación de capital. Capital: 39.900,39 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,39 Euros. Datos registrales. T 638 , F 189, S 8, H LO 11222, I/A 25 (12.01.12).
Declaración de unipersonalidad — 23/01/2012
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CEME HOLDINGS LLC. Datos registrales. T 638 , F 189, S 8, H LO 11222, I/A 26 (12.01.12).
Ceses/dimisiones — 08/09/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORRIOLS ARUMI XAVIER. Presidente: ORRIOLS ARUMI XAVIER. Consejero: PET-IBERIA SL. Vicepresid.: PET-IBERIA SL. Consejero: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL. SecreNoConsj: RIGAU TORNABELLS JOAN....
Nombramientos — 15/07/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLANUEVA FUENTE FRANCISCO JAVIER;EZQUERRA BASTIDA CRISTINA-MARIA. Datos BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 135 Viernes 15 de julio de 2011 Pág. 36050 cve: BORME-A-2011-135-26 regi...
Revocaciones — 15/07/2011
Revocaciones. Apoderado: ARNAL OTERO OSCAR;ARBIDE EMPARANZA ANASTASIO PABLO. Datos registrales. T 638 , F 189, S 8, H LO 11222, I/A 23 ( 6.07.11). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/19...
Revocaciones — 08/02/2011
Revocaciones. Apoderado: OLMO MENDEZ SEBASTIAN;HERNANDEZ ORTIZ ZARATE BERNARDO. Datos registrales. T 638 , F 188, S 8, H LO 11222, I/A 21 (28.01.11).
Ceses/dimisiones — 28/01/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: SOTO CONDE ANTONIO. Presidente: SOTO CONDE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: ORRIOLS ARUMI XAVIER. Presidente: ORRIOLS ARUMI XAVIER. Datos registrales. T 638 , F 188, S 8, H LO 11222, I/A 2...
Ceses/dimisiones — 14/01/2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: MADARIAGA NIEVES IÑIGO. Nombramientos. SecreNoConsj: RIGAU TORNABELLS JOAN. Datos registrales. T 638 , F 187, S 8, H LO 11222, I/A 16 ( 3.01.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm....
Revocaciones — 14/01/2011
Revocaciones. Apoderado: MADARIAGA NIEVES IÑIGO. Apo.Manc.: MADARIAGA NIEVES IÑIGO. Apo.Sol.: MADARIAGA NIEVES IÑIGO. Apoderado: ARRIETA ESTURO MARTA. Datos registrales. T 638 , F 187, S 8, H LO 11222, I/A 17 ( 3.01.11).
Revocaciones — 23/07/2010
Revocaciones. Apoderado: IOANNIS PETRIDES;PEREZ DE MENDIOLA GARCIA JAVIER CARLOS. Datos registrales. T 638 , F 187, S 8, H LO 11222, I/A 14 (14.07.10).
Nombramientos — 13/04/2010
Nombramientos. Presidente: SOTO CONDE ANTONIO. Reelecciones. Consejero: PET-IBERIA SL. Vicepresid.: PET-IBERIA SL. Consejero: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SA. Datos registrales. T 638 , F 186, S 8, H LO 11222, I/A 13 (30...
Revocaciones — 18/12/2009
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ESPRONCEDA JAVIER;BLASCO BLASCO JAVIER ANTONIO. Datos registrales. T 638 , F 186, S 8, H LO 11222, I/A 12 ( 4.12.09).
Revocaciones — 29/06/2009
Revocaciones. Apoderado: PRIETO ELVIRA ELIAS;VICTORIA GARCIA PABLO;HERRAIZ FAIXO FERRAN;BALCELLS GENE ANTON;ALVAREZ PIERA VICENTE;BALCELLS GENE ANTON. Datos registrales. T 638 , F 186, S 8, H LO 11222, I/A 10 ( 8.06.09).
Revocaciones — 29/06/2009
Revocaciones. Apoderado: RODA PEÑALVO JULIO;IRIARTE AXPE JUAN IGNACIO;VALVERDE FERNANDEZ MARIA;NAVARCORENA YANIZ FERNANDO;ALCARAZ LLADRO ANTONIO. Datos registrales. T 638 , F 186, S 8, H LO 11222, I/A 11 (19.06.09).