Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 13 tarjetas
11/05/2015 Sec. I Página web de la sociedad Madrid
Madrid-190926

Página web de la sociedad — 11/05/2015

Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.celistics.com. Datos registrales. T 30493 , F 96, S 8, H M 467308, I/A 55 (30.04.15).

14/10/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-411084

Nombramientos — 14/10/2014

Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ PARRAGA RAFAEL JOSE. Datos registrales. T 30493 , F 93, S 8, H M 467308, I/A 50 ( 2.10.14).

14/10/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-411085

Nombramientos — 14/10/2014

Nombramientos. Apoderado: PAJUELO GALLEGO ALFONSO JUAN. Datos registrales. T 30493 , F 94, S 8, H M 467308, I/A 51 ( 3.10.14).

14/10/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-411086

Revocaciones — 14/10/2014

Revocaciones. Apo.Sol.: RIERA ANDRES JOSE-LUIS. Datos registrales. T 30493 , F 95, S 8, H M 467308, I/A 52 ( 3.10.14).

14/10/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-411087

Nombramientos — 14/10/2014

Nombramientos. Apoderado: CERRO ZAHINO ISAIAS. Datos registrales. T 30493 , F 95, S 8, H M 467308, I/A 53 ( 3.10.14).

18/12/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-540369

Nombramientos — 18/12/2013

Nombramientos. Apoderado: BELFORT ISTURIZ ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 30493 , F 92, S 8, H M 467308, I/A 48 (10.12.13).

03/10/2013 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-424281

Cambio de domicilio social — 03/10/2013

Cambio de domicilio social. PLAZA DE COLON 2, PLANTA 15, TORRE I (MADRID). Datos registrales. T 30493 , F 91, S 8, H M 467308, I/A 46 (25.09.13).

03/10/2013 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-424282

Modificaciones estatutarias — 03/10/2013

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9º.MODIFICADO .ELIMINACION DEL ARTICULO 5º BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LAS CLASES DE PARTICIPACIONES.. Datos registrales. T 30493 , F 91, S 8, H M 467308, I/A 47 (25.0...

20/03/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-132437

Revocaciones — 20/03/2013

Revocaciones. Apoderado: ALEJANDRO CRASNY ZYMAN. Datos registrales. T 30493 , F 90, S 8, H M 467308, I/A 41 (11.03.13).

20/03/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-132438

Revocaciones — 20/03/2013

Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA NAVARRO JAVIER. Datos registrales. T 30493 , F 90, S 8, H M 467308, I/A 42 (11.03.13).

14/01/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-15949

Revocaciones — 14/01/2013

Revocaciones. Apoderado: DE MARTIN MUÑOZ JESUS ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: DE MARTIN MUÑOZ JESUS ALBERTO. Datos registrales. T 26792 , F 199, S 8, H M 467308, I/A 33 ( 3.01.13).

08/07/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-270393

Nombramientos — 08/07/2010

Nombramientos. Apoderado: RIERA ANDRES JOSE-LUIS. Datos registrales. T 26792 , F 194, S 8, H M 467308, I/A 24 (25.06.10).

08/07/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-270394

Nombramientos — 08/07/2010

Nombramientos. Consejero: BENSHIMOL CHONCHOL LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 26792 , F 194, S 8, H M 467308, I/A 25 (25.06.10).