Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 7 tarjetas
07/08/2019 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-346121

Cambio de denominación social — 07/08/2019

Cambio de denominación social. BEON FINANCE SL. Datos registrales. T 33317 , F 204, S 8, H M 599630, I/A 11 (31.07.19).

20/05/2019 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-211862

Cambio de domicilio social — 20/05/2019

Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 58 6ª (MADRID). Datos registrales. T 33317 , F 204, S 8, H M 599630, I/A 9 (10.05.19).

20/05/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-211863

Nombramientos — 20/05/2019

Nombramientos. Apoderado: MORO MARTIN MARIA JESUS. Datos registrales. T 33317 , F 204, S 8, H M 599630, I/A 10 (10.05.19).

31/10/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-436447

Revocaciones — 31/10/2018

Revocaciones. Apoderado: RAMBOUSEK YANN PIERRE. Datos registrales. T 33317 , F 203, S 8, H M 599630, I/A 8 (24.10.18).

30/10/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-433197

Ceses/dimisiones — 30/10/2018

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RUIZ DE AZCARATE VALERA JAVIER;BLASCO FILLOL SERGIO. Nombramientos. Representan: RODRIGUEZ CORCOLES PABLO. Adm. Solid.: BE ON IT SL;CHAVER MARTINEZ ANTON. Datos registrales. T 33317 , F 20...

06/06/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-238251

Nombramientos — 06/06/2018

Nombramientos. Apoderado: AREVALO AGUILAR ALBERTO. Datos registrales. T 33317 , F 202, S 8, H M 599630, I/A 6 (30.05.18).

29/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-139286

Nombramientos — 29/03/2016

Nombramientos. Apoderado: ROYO AGUIRRE ALFONSO JOSE. Datos registrales. T 33317 , F 79, S 8, H M 599630, I/A 4 (17.03.16).