Actos destacados
Revocaciones — 10/02/2026
Revocaciones. SecreNoConsj: AGUIRRE POLO IRANTZU. Nombramientos. SecreNoConsj: ERLAIZ COTELO IÑIGO. Datos registrales. S 8 , H AS 1263, I/A 56 ( 4.02.26).
Revocaciones — 10/02/2026
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ GUERRA MARIA DEL MAR. Nombramientos. Apo.Manc.: CORREAS GARCIA ALICIA. Datos registrales. S 8 , H AS 1263, I/A 57 ( 4.02.26).
Revocaciones — 18/11/2019
Revocaciones. Apo.Sol.: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A 41 ( 8.11.19).
Ceses/dimisiones — 24/10/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Vicepresid.: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS;PUJADES GONZALEZ JESUS;DIAZ MARTINEZ MARIA COVADONGA;GONZALEZ GO...
Ceses/dimisiones — 11/10/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 39 ( 2.10.19).
Ceses/dimisiones — 28/06/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 38 (21.06.19).
Ceses/dimisiones — 17/12/2018
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 36 ( 4.12.18).
Ampliación de capital — 17/12/2018
Ampliación de capital. Suscrito: 27.165,20 Euros. Desembolsado: 27.165,20 Euros. Resultante Suscrito: 273.575,20 Euros. Resultante Desembolsado: 273.575,20 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos:...
Nombramientos — 17/09/2018
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ ANDRES. Datos registrales. T 1065 , F 131, S 8, H AS 1263, I/A 34 ( 7.09.18).
Revocaciones — 17/09/2018
Revocaciones. Apoderado: SANZ CANGA JESUS HONORIO. Datos registrales. T 1065 , F 133, S 8, H AS 1263, I/A 35 ( 7.09.18).
Ceses/dimisiones — 03/09/2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARGONZALEZ MARTINEZ ANTONIO MANUEL. Presidente: ALVARGONZALEZ MARTINEZ ANTONIO MANUEL. Secretario: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Nombramientos. Presidente: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Secretario: GONZA...
Reelecciones — 29/12/2017
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 1065 , F 131, S 8, H AS 1263, I/A 32 (19.12.17).
Ceses/dimisiones — 13/12/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARGONZALEZ ROMAÑA LUIS JUAN JESUS;ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Presidente: ALVARGONZALEZ ROMAÑA LUIS JUAN JESUS. Vicepresid.: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Consejero: GONZALEZ ABARR...
Nombramientos — 02/06/2016
Nombramientos. Con.Delegado: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS 1263, I/A 30 (25.05.16).
Ceses/dimisiones — 25/05/2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: VILLAVERDE BARCALA ROGELIO. Consejero: VILLAVERDE BARCALA ROGELIO. Nombramientos. Secretario: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS 1263, I/A 29 (15.05...
Modificaciones estatutarias — 19/09/2012
Modificaciones estatutarias. 14. Funcionamiento Junta Gral.-. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.canteraslabelonga.es. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS 1263, I/A 27 ( 7.09....
Revocaciones — 26/10/2011
Revocaciones. Con.Delegado: DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL. Reelecciones. Consejero: ALVARGONZALEZ ROMAÑA LUIS JUAN JESUS;ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO-MELCHOR. Presidente: ALVARGONZALEZ ROMAÑA LUIS JUAN JESUS. Vicepresid.: GONZ...
Nombramientos — 26/10/2011
Nombramientos. Con.Delegado: DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1065 , F 104, S 8, H AS 1263, I/A 25 (14.10.11).