Actos destacados
Revocaciones — 08/06/2017
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA TORRES MANUEL. Apoderado: OUTEIRO VILLAR JESUS. Datos registrales. T 3438 , F 18, S 8, H C 23865, I/A 40 (31.05.17).
Revocaciones — 06/10/2016
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ PLAZA CARLOS. Datos registrales. T 3438 , F 17, S 8, H C 23865, I/A 38 (29.09.16).
Nombramientos — 06/10/2016
Nombramientos. Apoderado: ENCINAS LASTRA ALBERTO. Datos registrales. T 3438 , F 18, S 8, H C 23865, I/A 39 (29.09.16).
Revocaciones — 03/06/2016
Revocaciones. Apo.Manc.: CANO DE LA FUENTE JUANA;CANO DE LA FUENTE JUANA;LLANAS CARVAJAL DAVID;AÑON SEIJAS RICARDO;GARCIA MESURA RUBEN;CANO DE LA FUENTE JUANA;MEDIAVILLA CANO EVA. Datos registrales. T 3438 , F 17, S 8,...
Nombramientos — 18/02/2016
Nombramientos. Apo.Manc.: VILLAR SUAREZ MARIA ELENA;LLANAS CARBAJAL DAVID;GARCIA MESURA RUBEN;AÑON SEIJAS RICARDO;MEDIAVILLA CANO EVA. Datos registrales. T 3438 , F 17, S 8, H C 23865, I/A 36 (10.02.16).
Nombramientos — 01/02/2016
Nombramientos. Apoderado: CASAS ROBLA JESUS. Datos registrales. T 3438 , F 15, S 8, H C 23865, I/A 35 (25.01.16).
Nombramientos — 10/12/2014
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3438 , F 15, S 8, H C 23865, I/A 34 ( 1.12.14).
Reelecciones — 18/09/2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3438 , F 15, S 8, H C 23865, I/A 33 (10.09.13).
Nombramientos — 24/05/2013
Nombramientos. Vicesecret.: CUBEDO SANCHEZ BELEN. Datos registrales. T 3438 , F 14, S 8, H C 23865, I/A 30 (16.10.12).
Nombramientos — 24/05/2013
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PLAZA CARLOS. Datos registrales. T 3438 , F 14, S 8, H C 23865, I/A 32 (16.05.13).
Revocaciones — 22/05/2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALVO GARCIA BENAVIDES MARTA MARIA. Datos registrales. T 3438 , F 14, S 8, H C 23865, I/A 31 (16.05.13).
Reelecciones — 26/10/2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Otros conceptos: Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedadesde Capital. Datos registrales. T 2748 , F 177, S 8, H C 23865, I/A 29 (16.10.12).
Revocaciones — 13/06/2012
Revocaciones. Apoderado: LAZCOZ FRANCISCO JAVIER;MARCOS GARCIA EMILIO;LAZCOZ CISNEROS FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 2748 , F 176, S 8, H C 23865, I/A 27 ( 1.06.12).
Nombramientos — 13/06/2012
Nombramientos. Apoderado: ORGE MIGUEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 2748 , F 176, S 8, H C 23865, I/A 28 ( 1.06.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 111 Miércoles 13 de junio de 2012 Pág. 27181 cve: BORME-A-...
Reelecciones — 06/02/2012
Reelecciones. Consejero: CALVO GARCIA-BENAVIDES MANUEL. Cons.Del.Sol: CALVO GARCIA-BENAVIDES MANUEL. Datos registrales. T 2748 , F 176, S 8, H C 23865, I/A 26 (27.01.12).
Revocaciones — 01/02/2012
Revocaciones. Apo.Manc.: PORTEIRO EIROA EZEQUIEL;PORTEIRO EIROA EZEQUIEL;PORTEIRO EIROA EZEQUIEL. Datos registrales. T 2748 , F 176, S 8, H C 23865, I/A 25 (23.01.12).
Reelecciones — 16/09/2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2748 , F 176, S 8, H C 23865, I/A 24 ( 7.09.11).
Nombramientos — 02/08/2011
Nombramientos. Apoderado: LAZCOZ CISNEROS FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 2748 , F 175, S 8, H C 23865, I/A 23 BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 146 Martes 2 de agosto de 2011 Pág. 38872 cve: BORME-A-20...
Modificaciones estatutarias — 10/03/2011
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 2º: Relativo al OBJETO SOCIAL.- . Cambio de objeto social. Fabricación para todas las empresas de Grupo de envases de todo tipo de material, destinados al...
Reelecciones — 18/11/2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2748 , F 174, S 8, H C 23865, I/A 21 ( 9.11.10).
Reelecciones — 26/11/2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2748 , F 174, S 8, H C 23865, I/A 20 (17.11.09).