Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 6 tarjetas
27/11/2019 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-489664

Revocaciones — 27/11/2019

Revocaciones. ADM.UNICO: CORPORACION ZAMAP SL. REPR.143 RRM: GALLARDO BALLART JORGE. Nombramientos. CONSEJERO: GALLARDO BALLART JORGE. PRESIDENTE: GALLARDO BALLART JORGE. CONSEJERO: PIQUE DE VIU MARIA ANGELES;GALLARDO P...

27/11/2019 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-489666

Nombramientos — 27/11/2019

Nombramientos. APODERAD.SOL: GALLARDO BALLART JORGE. APOD.MANCOMU: CORPORACION ZAMAP SL;PIQUE DE VIU MARIA ANGELES;GALLARDO PIQUE JORGE;GALLARDO PIQUE CARLOS. Datos registrales. T 42366 , F 87, S 8, H B 254829, I/A 20 (...

05/11/2018 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-440442

Revocaciones — 05/11/2018

Revocaciones. APODERADO: CAZORLA AIGUABELLA JULIO;RODRIGUEZ POUSA JOSE;ROGER LOPPACHER JAVIER;SAEZ SANCHEZ VICTOR. APOD.MANCOMU: CAZORLA AIGUABELLA JULIO. Datos registrales. T 41625 , F 110, S 8, H B 254829, I/A 18 (25....

05/01/2015 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-731

Nombramientos — 05/01/2015

Nombramientos. APOD.MANCOMU: CAZORLA AIGUABELLA JULIO;ESTRELLES DOMINGO MANUEL JESUS;RODRIGUEZ POUSA JOSE;ROGER LOPPACHER JAVIER;SAEZ SANCHEZ VICTOR. Datos registrales. T 41625 , F 109, S 8, H B 254829, I/A 17 (24.12.14...

13/07/2012 Sec. I Ampliación de capital Barcelona
Barcelona-296551

Ampliación de capital — 13/07/2012

Ampliación de capital. Capital: 156.701.610,00 Euros. Resultante Suscrito: 276.906.860,00 Euros. Datos registrales. T 38659 , F 183, S 8, H B 254829, I/A 11 ( 4.07.12).

13/07/2012 Sec. I Otros conceptos: PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL Barcelona
Barcelona-296552

Otros conceptos: perdida del caracter de unipersonal — 13/07/2012

Otros conceptos: PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL. Datos registrales. T 38659 , F 185, S 8, H B 254829, I/A 12 ( 4.07.12).