Actos destacados
TransformaciÓn de empresas — 02/01/2013
Anuncio de transformación en fundación de carácter especial. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídi...
Otros conceptos: prorrogados hasta el 4-8-2012 los miembros de los órganos de gobierno de la caja de ahorros municipal de burgos según la d — 10/08/2012
Otros conceptos: Prorrogados hasta el 4-8-2012 los miembros de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos según la D.T.3& del D.L. 2/2010 de Castilla León, ampliado por la D. Ad.2& de la ley 17/20...
Revocaciones — 24/11/2011
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA NUÑEZ LEONCIO. Nombramientos. Apo.Sol.: BARBERO MARTIN RAFAEL. Otros conceptos: Revocado el poder a favor de don Leoncio García Nuñez que se confirió en inscripción 393. Datos registrales....
Ceses/dimisiones — 29/09/2011
Ceses/Dimisiones. Dir. General: GARCIA NUÑEZ LEONCIO. Nombramientos. Dir. General: BARBERO MARTIN RAFAEL. Datos registrales. T 580, L 371, F 148, S 8, H BU 1669, I/A 535 (20.09.11).
Ceses/dimisiones — 29/06/2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: ARRIBAS MORAL JOSE MARIA. Consejero: ARRIBAS MORAL JOSE MARIA. Miem.Com.Ej.: ARRIBAS MORAL JOSE MARIA. Pres.Com.Ej.: ARRIBAS MORAL JOSE MARIA. Nombramientos. Presidente: LEAL VILLALBA JOSE...
Revocaciones — 28/06/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO CRESPO ADOLFO;MIGUEL COSSIO FRANCISCO;SEDANO ALONSO LAURA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PORRAS SAGREDO JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 580, L 371, F 145, S 8, H BU 1669, I/A 532 (...
Nombramientos — 28/06/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ SERNA ALVARO. Datos registrales. T 580, L 371, F 144, S 8, H BU 1669, I/A 531 (16.06.11).
Revocaciones — 17/06/2011
Revocaciones. Apo.Sol.: VELEZ GALINDO MARIA CARMEN. Apoderado: ARNAIZ HORTIGUELA MARIA. Apo.Man.Soli: BARAHONA TAPIA JOSE. Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ GOMEZ ISMAEL. Datos registrales. T 580, L 371, F 143, S 8, H B...
Nombramientos — 10/05/2011
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ SAENZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 580, L 371, F 142, S 8, H BU 1669, I/A 529 (28.04.11).
Nombramientos — 11/04/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPIGA AMURRIO OSCAR JOSE. Datos registrales. T 580, L 371, F 138, S 8, H BU 1669, I/A 526 (31.03.11).
Nombramientos — 11/04/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PROVENCIO FERNANDEZ ALBERTO. Datos registrales. T 580, L 371, F 138, S 8, H BU 1669, I/A 527 (31.03.11).
Revocaciones — 11/04/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ MUÑIZ BALLESTEROS LUIS;LOPEZ MUÑIZ BALLESTEROS LUIS;REVUELTA GOMEZ JUAN;PARAMO NEBREDA CELIA;VELEZ GALINDO MARIA CARMEN. Apoderado: GARCIA PABLOS GUDEN. Apo.Man.Soli: PEREZ SERNA ALVARO...
Nombramientos — 11/04/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOLDARACENA IDOATE MARIA ASUNCION;VILLANUEVA ORBAIZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 580, L 371, F 137, S 8, H BU 1669, I/A 525 (31.03.11).
Nombramientos — 23/02/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN RAYA ANA MARIA. Datos registrales. T 580, L 371, F 134, S 8, H BU 1669, I/A 523 (14.02.11).
Revocaciones — 23/02/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LORENTE FERNANDEZ AMAYA;RUIZ-CLAVIJO GARCIA MARIA TERESA;MENENDEZ ESCRIBANO MARIO. Apoderado: PROVENCIO FERNANDEZ ALBERTO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ-CLAVIJO GARCIA MARIA TERESA. Datos...
Revocaciones — 31/01/2011
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 580, L 371, F 133, S 8, H BU 1669, I/A 522 (20.01.11).
Otros conceptos: depositado proyecto de modificacion del contrato de integracion del grupo banca civica (del que forma parte caja municipal de burgos) con la incorporacion de monte de piedad y caja de ahorros de san fernando de guadalajara, huelva, jerez ysevilla (cajasol), en expediente 19/2010/libro de proyectos — 30/12/2010
Otros conceptos: DEPOSITADO PROYECTO DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE INTEGRACION DEL GRUPO BANCA CIVICA (DEL QUE FORMA PARTE CAJA MUNICIPAL DE BURGOS) CON LA INCORPORACION DE MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE SAN FER...
Nombramientos — 27/12/2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ CID BEATRIZ;GARCIA IZQUIERDO SERGIO;BENITO BENITO BEGOÑA;LOPEZ PARAMO JUDIT. Datos registrales. T 580, L 371, F 128, S 8, H BU 1669, I/A 518 (14.12.10).
Nombramientos — 27/12/2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: URIEN GARCIA DIEGO. Datos registrales. T 580, L 371, F 129, S 8, H BU 1669, I/A 519 (14.12.10).
Revocaciones — 27/12/2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ MARTINEZ JESUS;VARAS CARCEDO JAIME;AREVALO SANCHEZ TOMAS JOSE. Apoderado: BARAHONA TAPIA JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARAHONA TAPIA JOSE;AREVALO SANCHEZ TOMAS JOSE. Datos registr...
Revocaciones — 27/12/2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA ILLERA NOELIA;CALZADA DE LA FUENTE FRANCISCO JAVIER;OJOSNEGROS MUÑOZ JOSE ALBERTO;BARCENILLA TAMAYO RAQUEL. Apo.Sol.: AUSIN REVILLA TOMAS;PEREZ MARTINEZ JESUS;BARCENILLA TAMAYO RAQUEL;...
Revocaciones — 13/12/2010
Revocaciones. Apoderado: DOMINGUEZ ANTON JUAN PABLO. Apo.Man.Soli: MARTIN ARAGON RAUL. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA DIEGO. Datos registrales. T 580, L 371, F 127, S 8, H BU 1669, I/A 517 (30.11.10).
Revocaciones — 18/11/2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ORIVE LOPEZ DIEGO. Apo.Manc.: ABELLA ORTIZ SANDRA;SANCHEZ MARTINEZ JAVIER;MUNGUIRA VADILLO VANESA. Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ BENAVIDES MARTA;GARCIA BARANDA CINTIA. Datos registrales....
Revocaciones — 18/11/2010
Revocaciones. Apoderado: MOLINELLO JIMENEZ RAQUEL. Nombramientos. Apoderado: MOLINELLO JIMENEZ RAQUEL. Datos registrales. T 580, L 371, F 121, S 8, H BU 1669, I/A 512 ( 9.11.10).