Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2013 13 tarjetas
29/04/2013 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-200738

Revocaciones — 29/04/2013

Revocaciones. Apo.Manc.: DIAZ UGARRIO MARIA LUISA. Apo.Sol.: DIAZ UGARRIO MARIA LUISA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ HOLGADO JOSE LUIS. Apo.Sol.: RODRIGUEZ HOLGADO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1445 , F 209, S 8, H TO 29680, I...

10/12/2012 Sec. I Situación concursal Toledo
Toledo-509552

Situación concursal — 10/12/2012

Situación concursal. Procedimiento concursal 95/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 9/11/2011. Auto de declaración de concurso. BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 235 Lunes 10 de diciembre de 2012 Pág. 55127 c...

16/08/2012 Sec. I Situación concursal Toledo
Toledo-344385

Situación concursal — 16/08/2012

Situación concursal. Procedimiento concursal 95/2012. FIRME: No, Fecha de resolución 9/07/2012. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO. J...

28/03/2012 Sec. I Reducción de capital Toledo
Toledo-145141

Reducción de capital — 28/03/2012

Reducción de capital. Importe reducción: 565.776,00 Euros. Resultante Suscrito: 777.942,00 Euros. Datos registrales. T 1534 , F 193, S 8, H TO 29680, I/A 13 (19.03.12).

26/12/2011 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-515320

Nombramientos — 26/12/2011

Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ LOPEZ ANGEL. Datos registrales. T 1504 , F 102, S 8, H TO 29680, I/A 10 (15.12.11).

26/12/2011 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-515321

Revocaciones — 26/12/2011

Revocaciones. Apoderado: CUESTA MARTIN PALANCO JUSTINIANO. Datos registrales. T 1534 , F 191, S 8, H TO 29680, I/A 11 (15.12.11).

26/12/2011 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-515322

Nombramientos — 26/12/2011

Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ UGARRIO MARIA LUISA;RODRIGUEZ HOLGADO JOSE LUIS. Apo.Manc.: DIAZ UGARRIO MARIA LUISA;RODRIGUEZ HOLGADO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1534 , F 191, S 8, H TO 29680, I/A 12 (15.12.11).

28/11/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Toledo
Toledo-475173

Ceses/dimisiones — 28/11/2011

Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ MORENO JUAN CARLOS. Consejero: MARTINEZ MORENO JUAN CARLOS;CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION SA;PINILLA NAVALMORAL JUAN. Secretario: SAUGAR SEGARRA MARIO. Nombramientos. Adm. Man...

03/08/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Toledo
Toledo-324353

Ceses/dimisiones — 03/08/2011

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: AVILA GONZALEZ JUAN. Consejero: AVILA GONZALEZ JUAN;RICO CELAYA ANTONIO. Nombramientos. Consejero: CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION SA. Datos registrales. T 1504 , F 101, S 8, H TO 296...

31/08/2010 Sec. I Reducción de capital Toledo
Toledo-336867

Reducción de capital — 31/08/2010

Reducción de capital. Importe reducción: 70.722,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.343.718,00 Euros. Datos registrales. T 1451 , F 115, S 8, H TO 29680, I/A 7 (19.08.10).

30/10/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Toledo
Toledo-456249

Ceses/dimisiones — 30/10/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: LUJAN ALZALLU ANTERO. Vicepresid.: MARTINEZ ORTEGA MIGUEL ANGEL. Consejero: MARTINEZ ORTEGA MIGUEL ANGEL;SANCHEZ BODALO JOSE FERNANDO. Presidente: SANCHEZ BODALO JOSE FERNANDO. Nombramientos...

29/01/2009 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-50236

Nombramientos — 29/01/2009

Nombramientos. Auditor: ABACO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1451 , F 115, S 8, H TO 29680, I/A 5 (19.01.09).

13/01/2009 Sec. I Ampliación de capital Toledo
Toledo-17510

Ampliación de capital — 13/01/2009

Ampliación de capital. Suscrito: 54.240,00 Euros. Desembolsado: 54.240,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.414.440,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.414.440,00 Euros. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: SGO VIA...